The Royal Gazette / Royale (15/01/21) 504241 Rg20150121

User Manual: 504241

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 32

DownloadThe Royal Gazette / Royale (15/01/21) 504241 Rg20150121
Open PDF In BrowserView PDF
The Royal
Gazette

Gazette
royale

Fredericton
New Brunswick

Fredericton
Nouveau-Brunswick
ISSN 1714-9428

Vol. 173

Wednesday, January 21, 2015 / Le mercredi 21 janvier 2015

Notice to Readers

61

Avis aux lecteurs

The Royal Gazette is officially published on-line.

La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne.

Except for formatting, documents are published in The
Royal Gazette as submitted.

Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dans
la Gazette royale tels que soumis.

Material submitted for publication must be received by
the Royal Gazette Coordinator no later than noon, at least
seven working days prior to Wednesday’s publication.
However, when there is a public holiday, please contact
the Royal Gazette Coordinator at 453-8372.

Les documents à publier doivent parvenir à la coordonnatrice de la Gazette royale, à midi, au moins sept jours
ouvrables avant le mercredi de publication. En cas de jour
férié, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de la
Gazette royale au 453-8372.

Elections
New Brunswick

Élections
Nouveau-Brunswick

30

LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF SAINT JOHN EAST (District No. 30) / ASSOCIATION DU PARTI
LIBÉRAL DE SAINT JOHN-EST (Circonscription no 30)
Official Agent / Agent officiel

Tom Davidson
9, rue Alpine Street
Saint John, NB E2J 2X3

The Royal Gazette — January 21, 2015

62

Business Corporations Act

Gazette royale — 21 janvier 2015

Loi sur les corporations
commerciales

Notice of a decision to dissolve provincial corporations and to
cancel the registration of extra-provincial corporations

Avis d’une décision de dissoudre les corporations provinciales
et d’annuler l’enregistrement des corporations extraprovinciales

Notice of decision to dissolve provincial corporations
Take notice that the Director under the Business Corporations Act has
made a decision to dissolve the following corporations pursuant to
paragraph 139(1)(c) of the Act, as the said corporations have been in
default in sending to the Director fees, notices, and/or documents required by the Act. Please note that 60 days after the date of publication
of this Notice in The Royal Gazette, the Director may dissolve the
corporations.

Avis d’une décision de dissoudre les corporations provinciales
Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations
commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations suivantes en vertu de l’alinéa 139(1)c) de la Loi, puisque lesdites corporations ont fait défaut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/
ou documents requis par la Loi. Soyez avisé que 60 jours après la date
de la publication du présent avis dans la Gazette royale, le Directeur
pourra dissoudre lesdites corporations.

001900
051342
051521
051526
051532
056499
058783
059301
059435
636431
504197
506451
511146
511244
511318
511319
515980
516071
516195
605106
605251
605424
605444
611144
616950
617127
617156
617255
617330
617335
623573
623644
623672
623694
623707
624052
624063
630036
630068
630336
636476
636498
636682
636791
636798
636823
643047
643175
649120
649469
649493
655621
655680
655684
655752

001900 N.B. Inc.
051342 N.B. LTD.
051521 N.B. LTD.
051526 N.B. LTD.
051532 N.B. LTD.
056499 N.B. LTD.
058783 N.B. LTD.
059301 N.B. LTD.
059435 N.B. LTD.
3409 RUE PRINCIPALE INC.
504197 N.B. LTD.
506451 N.B. LTD.
511146 N.B. Ltd.
511244 N.B. Inc.
511318 N.B. LTD.
511319 N.B. Ltd.
515980 N.B. Ltd.
516071 N.B. Ltd
516195 N.B. Ltd.
605106 N.B. INC.
605251 N.B. LTD.
605424 N.-B. Ltée
605444 N.B. INC.
611144 NOUVEAU-BRUNSWICK
CORPORATION 611144 NEW
BRUNSWICK CORPORATION
616950 N.B. Ltd.
617127 N.B. LTD.
617156 NB Ltée 617156 NB Ltd.
617255 N.B. Ltd.
617330 NB Ltd.
617335 N.B. Inc.
623573 New Brunswick Ltd.
623644 NB Inc.
623672 NB Ltd.
623694 NB LTEE
623707 NB Ltd.
624052 N.B. Inc.
624063 N.B. Inc.
630036 N.B. Ltd.
630068 NB LTD.
630336 N.B. INC.
636476 N.B. Ltd. / 636476 NB Ltee
636498 NB LTD.
636682 NB INC.
636791 N.B. Ltd.
636798 N.B. Ltd.
636823 N.-B. INC.
643047 N.B. Inc.
643175 N.-B. Inc.
649120 NB INC.
649469 NB Inc.
649493 N.B. Ltd.
655621 N.B. LTD.
655680 N.B. Ltd.
655684 NB LTD.
655752 N.B. Ltd.

655838
655868
655901
655904
661958
661974
662015
662041
662080
662081
662082
662179
662205
662267
662285
662287
662364
662375
662391
662400
662413
668242
668291
668334
668607
668744
668756
668831
668856
668916
051529
662083
642738
008760
610884
668261
655763
668720
624028
501582
649137
662264
000647
643184
611036
605478
605236
662118
649092
617126
605384
662050

655838 NB Inc.
655868 N.B. LTD.
655901 NB INC.
655904 NB Inc.
661958 N.B. Ltd.
661974 N.B. Inc.
662015 N.B. Ltd.
662041 NB Inc.
662080 N.B. LTD.
662081 N.B. INC.
662082 Nouveau-Brunswick Inc.
662179 NB Inc.
662205 N.B. Inc.
662267 N.-B. INC.
662285 NB INC.
662287 N.B. INC.
662364 N.B. Ltd.
662375 N.B. Inc.
662391 N.B. Ltd.
662400 NB Inc.
662413 N.B. Inc.
668242 NB LTD.
668291 NB Inc.
668334 N.B. Inc.
668607 N.B. Ltd.
668744 N.-B. Ltée
668756 N.B. Inc.
668831 NB INC.
668856 NB LTD.
668916 NB Ltd.
A & J CONSTRUCTION LTD.
A & M Rentals Ltd.
A. BERTIN & FILS LTÉE - A BERTIN &
SON LTD.
A. G. JEAN LTEE.
ABC Adventures Ltd.
Adica Group Inc.
AEG Innovation & Design Inc.
AIRLOK INSULATION LTD.
AJM HOLDINGS INC.
ALDOUANE AQUACULTURE LTEE.
Alma Park Store Ltd.
ALTROLS CONTRACTING INC.
APPLEWOOD ACRES LTD.
Arctic Light Construction Ltd.
ARSENICK CORPORATION
ATCON PROPERTY HOLDINGS INC.
ATCON STRUCTURES INC.
Atlantic College of Information
Technology / Collège des Technologies
de l’Information de l’Atlantique Inc.
Avonmark Capital Limited
Balticum Business Group Ltd.
BARTHOLOMEW RIVER
DEVELOPMENT LTD.
BASALTIC SOLUTIONS INC.

053516 BEJEWEL BY TRUDY GALLAGHER
LTD.
617089 BELLEISLE GARDENS
GREENHOUSE NURSERY INC.
636412 BERNCOR HOLDINGS LTD.
514012 BH STATION SERVICE LTEE
668843 Blue Sky Properties Ltd.
668646 Bob & Ron’s Transportation Ltd.
043954 BOBA HOLDINGS INC.
636896 Boom Crane Rental Services Limited
623604 Boucher Sales Ltd.
642781 Boum Distribution and Marketing Inc.
623632 Brantville Acquaculture Ltee.
033260 BRASETTE LA CHALOUPE LTEE
059454 BREAK 4 LOGGING LTD.
649312 Brew-Tec Concrete Ltd.
649232 Bruce Brown Construction and
Renovation Ltd.
605454 BRUNSWICK PLUMBING SERVICES
LTD.
656032 Burgess Freight Carriers Inc.
002678 C & K ENTERPRISES LTD.
002747 CABOT LUMBER LTD.
611158 Caledonia Collision Center Inc.
056716 CAMCO CONSTRUCTION LTD.
642667 Capital Airways Inc.
003127 CAROL HOLDINGS LTD.
668617 CAS Roofing & Siding Ltd.
046241 CASEY SPRING LUMBER LTD.
048737 CHALEUR AUTO SERVICE LTD./
LTEE
610802 Chester Holdings Ltd.
508759 Classic Comfort Company Ltd.
053609 COCAGNE EXCAVATING LTD.
668822 Cold Fall Corporation
516190 CONCEPT PED HOLDING INC.
636430 Corporation professionnelle Dre AdamaRabi Youla MD Inc.
046708 CROWN FENCE SUPPLY LTD.
668299 Cut-er-All Concrete Sawing and Drilling
Ltd.
616946 D & R Custom Cedar Inc.
031618 D. & M. CRANE RENTAL LTD.
041291 D.E.M. HOLDINGS INC.
662401 DAKIN’S CONTRACTING LTD.
056671 DALEY FAMILY HOLDINGS LTD.
501852 DALY INVESTMENTS LTD.
636429 DAN DOUCET CONSULTANT INC.
662232 Daniel Castonguay Holdings Inc.
668091 Davenport Trucking Inc.
630470 DAVID & ABRAHAM INC.
668627 David H. Dunsmuir (2013) Professional
Corporation
636635 Deke’s Enterprises Ltd.
004891 DELUXE FISH & CHIPS LTD. DELUXE FISH & CHIPS LTEE
648693 Dépanneur Guitard Inc.

The Royal Gazette — January 21, 2015
513964 Dépanneur Léger Inc.
038934 DES’S FURNITURE REFINISHING
(1987) LTD.
636750 DESIGN 4 SPACE INC.
623831 Double Diamond Management Ltd.
044015 DOUG CHASE ENTERPRISES LTD.
668919 DOWNFORCE AUTOWORKS INC.
617360 Dr Frédéric Goguen c.p. Inc.
605210 DR. DENISE DUGUAY-VIBERT
CORPORATION
PROFESSIONNELLE INC.
655683 Dr. Matthieu Gaudet Corporation
Professionnelle Inc.
668608 Dr. Oludara-Fadare P.C. Inc.
508849 Dr. Peter Feero P.C. Inc.
649198 Dr. S.M.P. Tran Professional Corporation
051469 DR. T. TOUDJIAN PROFESSIONAL
CORPORATION
516205 Dre MÉLANIE CHAREST C.P. INC.
668243 Dre Micheline Boucher-Robichaud C.P.
Inc.
514025 Dream Kitchen Plus Ltd.
649581 DROST CONSTRUCTION INC.
041305 E. F. CHRISTIE & SONS INC.
516300 Eastern Canadian Maple Products Inc./
Produits d’Erable de l’Est canadien Inc.
605455 EastServe GroundsCare Inc.
655731 EDWARD DOIRON CONSULTING
LTD.
041389 EFFECTIVE PARTICLE
TECHNOLOGIES LTD.
649434 Egg Films NB Inc.
617376 ELEMENTAL CODEWORKS INC.
668681 ELLE EST BELLE SERVICES CORP.
636745 Embracor Ltd.
623553 EMC Executive Management Consulting
Inc.
656091 ENCORE ATM-POS INC./ENCORE
GAB-TPV INC.
655632 Enigma Movie and Scripts Corporation
668695 ENTER RENOVATIONS INC.
630447 ENTREPRISES J.V.L. INC.
030082 ENTREPRISES MALLET LIMITEE
630438 ESQU CERTIFIED LTD.
636759 F & G EURO FLOORING LTD.
662280 Faithful Servant Books Inc.
059494 FERME ARMAND GODBOUT LTEE
656092 Ferme J & D.L. Farms Inc.
605394 FISH-ON-BAIT COMPANY, CANADA
LTD.
649259 FourJ Steel Incorporated
662099 Franzen Canada Corp.
649531 FRESH FROM THE SEA LTD.
504231 FROSTY HOLLOW SYLVACULTURE
& LOGGING INC.
668913 FUNDY LASERFAB LTD.
511192 G.A. DUNCAN ELECTRIC LTD.
655770 GERT’S PLACE INC.
053525 GESTION B & M MICHAUD LTEE
007089 GESTION MOCO LIMITEE
501725 GESTION R. CYR MANAGEMENT
INC.
504171 GLENCO HYDROSPRAYER LTD.
053610 GLOBAL MECHANICAL SYSTEMS
LTD.
501732 GOLD COAST MARINE
CONSULTANT INC.
059440 GOLDEN SISTERS LIMITED
053399 GOULD’S FRIED CLAMS LTD.
007503 GREEN’S RESTAURANT LIMITED
662274 GROUNDS EFFECTS LANDSCAPING
LTD.
034987 HAINES PHARMACY LTD.
668315 HDR Motorsports Ltd.
649464 Headway Rehabilitation Inc.
668325 hearingaidrental.ca Ltd.
642758 Hickory Holdings Ltd.
031531 HOLLAND FOOD IMPORTS LTD.
504241 HYDRA-FAB INDUSTRIAL INC.

63
516283
655940
668781
668348
041207
034901
623990
636817
052315
668939
617188
668895
610893
649479
504084
059532
056585
662380
616869
656066
513951
668592
504116
008462
049264
616998
662173
668905
649562
668276
655790
649440
668342
649563
031534
642879
642953
649388
056335
516166
642791
668302
516251
649345
668824
516275
030124
010241
501710
617025
511266
649280
051461
516343
605419
010409
516276
010749
010768
011742
010823
010889
056521
513948
038874
605267
655708
662342

Ian J. Warren Ltd.
IFJ West Holdings Ltd.
IMEX Sourcing Inc.
Immilease Inc.
IMPRESSION PROMOTION LTD.
INDIAN ISLAND VACATIONS INC.
INDUSTRIAL HYDRO-VAC NB LTD.
INSTITUT BEAUBASSIN INC.
INSTITUT EDUKA INC.
Intergrated Systems Consulting Inc.
INVESTISSEMENTS DDH INC.
Iron Wolf Mining Inc.
J & J Cummings Housing Ltd.
J. Cloutier Professional Corporation
J.K.S.V. ENTERPRISES LTD.
J.S. SHIPBUILDING CONSULTANTS
LTD.
JAMES F. IZZARD PROFESSIONAL
CORPORATION
Jamie Cummings Housing &
Development Ltd.
JEMDAC INC.
Jenta Engineered Solutions Ltd.
JIM’S FAMILY CONVENIENCE
STORE LTD.
Joel’s Pizza Inc.
JOGE ENTREPRISE LTD
JOHN L. INGERSOLL & SONS LTD.
JOHN MCGUIRE SALES LTD.
John Mick Inc.
JVY TRANSPORT INC.
K & L Electric Ltd.
KA&LMD Holdings Inc.
Kentin Forestry Inc.
KHD - KustomHAUS Designs Inc.
Knight North America Corp.
KST Tech Group Inc.
L&KAMD Investments Inc.
LAITERIE MARTEL LTEE
Landi Investments Inc.
Le coin des pecheurs 2009 Inc.
Le Restaurant Familial Jac-Pit Inc.
LES ENTREPRISES HARRY FRYE
LTEE
Les entreprises Lanwon Inc./Lanwon
Enterprises Inc.
LET’S PLAY ENTERTAINMENT LTD.
LinkState Technologies, Inc.
Little Sneakers Daycare Inc.
LOAAT CONSULTING (N.B.) INC.
LONE TREE VENTURES INC.
LONGING VENTURES INC.
M. J. SCHMIDT & SON LTD.
M. T. A. SALES LTD.
M.C. TRIMMING & CUTTING TREE
LTD
M.D. PELLERIN LUMBER INC.
M.P. AQUACULTURE INC.
M.R. Service Center Ltd.
MACDOUGALL’S FARM LTD.
MacKELLAR CUNNINGHAM &
ASSOCIATES LTD.
MacPherson Group Limited
MAPLE GROVE TRAILER PARK LTD.
Marco & Clarence Forestiere Ltee
MATTHEWS BROS. LTD.
MAYFAIR BEVERAGE ROOM (1979)
LTD.
MCKINNEY MANAGEMENT
SERVICES LTD.
MEL ENTERPRISES LTD.
MERV’S CATERING RESTAURANT &
BAKERY LTD.
Metlantech Inc.
MILLIGAN’S CYCLE WORKS INC.
MINTO FINE FURNITURE LTD
Miramichi Career College Inc.
mode de vie Carelle’s lifestyle Inc.
MONEY CAFE INC.

Gazette royale — 21 janvier 2015
011397
649333
610888
668633
668341
655915
668872
668647
506522
649208
656036
668864
655704
511373
511092
636920
662167
013132
049213
041390
516238
649154
504083
649256
605323
623574
031434
668701
516191
649067
649354
506432
056436
056575
655642
610911
623625
034899
513913
642905
624015
014502
643022
623648
044000
643001
014961
617366
662146
668860
053464
649285
041224
668845
668593
655742
654456
015451
668873
630251
043944
636897
668591
668308
630163
668680

MORUE IMPERIALE LTEE
MSL Carriers Ltd.
MULTI-RECYCLING LTD.
N.J.E. Enterprises Inc.
North East Paper Inc.
NRG Durable Inc./Durable NRG Inc.
O.I. Holdings Inc.
onVDO Corporation
P & A TIMBER INC.
Palmer Management Services Ltd.
Panacea Body Wellness Centres (NB)
Limited
PARA BEAUTY INC.
Patient Television Services Inc.
PATRICK L. MURCHISON
PROFESSIONAL CORPORATION
PCS LabMentors LTD.
PERPETUAL SECURITY
CORPORATION
Pièces Parts Expert Inc.
PINES ENTERPRISES LTD.
PORCHERIE DU CENTRE V.T. INC
POWER PLAY SPORTS & HOCKEY
CLINICS INC.
PRATIQUE MEDICALE CORMIER &
OUELLETTE C.P. INC.
Premium ESL Canada Inc.
PRINCE EDWARD DEVELOPMENTS
LIMITED
Profloor Installs Ltd.
PRS Enterprises Ltd.
R & S Mining Consultants Inc.
R. LANDRY HOLDING LTD.
R.W. Morton Construction Inc.
RESIDENCE COMPLEXE
BONACCORD INC.
RESTIGOUCHE AQUACULTURE
LTD.
Restigouche Centre of Excellence in
Athletic Skill Development Inc.
REYNOLDS RV SALES LTD.
RICHARD SHEET METAL LTD.
RITCHIE’S PLUMBING & HEATING
INC.
River Bend Consulting Inc.
RIVERSIDE COACH LINES INC.
Riverview Comfort Inc.
RIVERVIEW MUFFLER CENTER LTD.
RMLE Location Ltée
ROWCOR Technologies Inc
S.A. ORR & SEARS LTD.
SABRA LIMITED
San Wen Feng Shui Planning Corporation
Inc.
Savage’s Bicycle Centre Inc.
SCOTT IRVING SHEET METAL LTD.
SEA DREAM FISHERIES LTD.
SECURITY PHOTO PROFILE LTD.
SERGE H. BRIDEAU GARAGE &
SCRAP METALS LTD
Serre APOLO Greenhouse Inc.
SGN Construction Management Inc.
SHAMROCK HOLDINGS LTD.
Silver Daisy Designs Inc.
SILVER HARVEST LTD.
Smile a While Dairy Bar Inc.
Snack & Bevy Shack Inc.
Solstice Soap Co. Inc.
Spa Chance Harbour inc.
SPENCER TRUCKING LIMITED
Stephen LeBlanc Financial & Investment
Services Ltd.
Stewart & Stevenson Canada Inc.
STIEF LTD.
Sugar Island Foods Inc.
SUITE SERENDIPITY LTD.
Sunray Solar Inc.
Sunrise Diner Ltd.
Supreme Energy Centre Inc.

The Royal Gazette — January 21, 2015
660458
649118
617294
655913
668323
053283
668238
049197
508779

Synergy Properties Inc.
T & G Holdings Incorporated
T.J. MAILLET RESIDENCES LTD.
Taylor Lake Aggregates Inc.
TECHVEDIC NEW BRUNSWICK INC.
TEDISH HOLDING LTD.
Telefoniks Digital Inc.
TexMedico Inc.
The Washburn Group Financial Advisors
Inc.
056515 TILLEY TAKE-OUT LTD.
662332 TJM ENTERPRISES INC.

64
623977
610775
617300
016369
636793
668786
016657
649568
643170
649127

Gazette royale — 21 janvier 2015

Tom Egers Excavating Ltd.
Transport 04 Inc.
Travacom Properties Inc.
TRI-GIL PAVING & CONSTRUCTION
LTD
Tritium Software Inc.
TruGreen Landscaping Ltd.
VALLEY DISTRIBUTORS LTD.
Verge Point Construction Ltd.
VICTORIA GROWERS LTD.
Vista Ridge Homes Inc.

051421 VOLUME TRUCK & EQUIPMENT
SALES LTD.
016898 WALKER & ASSOCIATES LTD.
636828 Waveney Holdings Inc.
617187 WEST-WOOD MANUFACTURING
LTD.
662147 Wet to Dry Basement Solutions Inc.
030116 WINDOWS INTERNATIONAL SALES
& INSTALLATION LTD.
610966 XTRA PC INC.
617303 ZEAN’S AUTO REPAIR LTD.
668841 Zliv Creations Inc.

____________________

____________________

Notice of decision
to cancel the registration of extra-provincial corporations
Take notice that the Director under the Business Corporations Act has
made a decision to cancel the registration of the following extraprovincial corporations pursuant to paragraph 201(1)(a) of the Act, as
the said corporations have been in default in sending to the Director
fees, notices, and/or documents required by the Act. Please note that
60 days after the publication of this Notice in The Royal Gazette, the
Director may cancel the registration.

Avis d’une décision
d’annuler l’enregistrement des corporations extraprovinciales
Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations
commerciales, a pris la décision d’annuler l’enregistrement des corporations extraprovinciales suivantes en vertu de l’alinéa 201(1)a) de la
Loi, puisque lesdites corporations ont fait défaut de faire parvenir au
Directeur les droits, avis et/ou documents requis par la Loi. Soyez avisé
que 60 jours après la date de la publication du présent avis dans la
Gazette royale, le Directeur pourra annuler l’enregistrement desdites
corporations extraprovinciales.

655809
636597
662144
662197
668752
623612
636785
668597
076635
649048

662126
649099
636853
073144
630088

2081109 ONTARIO INC.
3089-2400 Québec Inc.
8078637 Canada Inc.
8100896 Canada Inc.
8407690 Canada Inc.
Advantage Communications Inc.
AKVA group North America Inc.
Alimentation L’épicier inc.
ALLIED INTERNATIONAL CREDIT
CORP./SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
DE RECOUVREMENT ALLIED INC.
ASSET APPRAISAL SERVICES
(CANADA) INC. SERVICE
D’ÉVALUATION D’ÉQUIPEMENTS
(CANADA) INC.
Breakwater Resources Ltd.
Centric Disability Management Inc.
CLOVERCONCEPT INVESTMENTS
LTD.
COMSTOCK CANADA LTD.
Connor, Clark & Lunn Private Capital Ltd.

624030
668736
649065
662115
630047
649590
073624
630384
668868
661810
623968
630385
654367
668163
655956
078090
643051

DR CHARLES JOURNET P.C. INC.
DTComposite Ltée
Dynamic Tire Corp.
Edulife Centre Eduvie Inc.
Entreprises forestières sapins Verte inc
Futurebright Insurance Group Inc./Groupe
Assurances Futurebright Inc.
GOJIT INC.
GROUPE MÉGA SERVICE INC.
HOLLOWAY LODGING
CORPORATION
IAM Building Systems Inc.
IGRI INC.
J. H. SAUVÉ ET FILS (1979) INC.
KARRYS BROS., LIMITED
Les Gestions Lecram Ltée.
Les Systèmes Equinox Inc.
MILLER INTERMODAL LOGISTICS
SERVICES, INC.
NEXIM CANADA INC.

078062 Nortel Networks Technology
Corporation/Corporation Technologie
Nortel Networks
668255 PIONEER FUELS INC.
661998 Point Zero One Realty Limited
630300 QUADRA CHEMICALS LTD.
624044 QUANTUM MURRAY GP INC.
019661 SEAMARK ASSET MANAGEMENT
LTD.
668734 SHS SERVICES MANAGEMENT INC
GESTION DES SERVICES SHS INC.
629804 TD SERVICES PLUS INC.
662372 TECHNOLOGIES SYNERSTAR INC.
SYNERSTAR TECHNOLOGIES INC.
077560 W.T. RAWLEIGH CO.
662388 WEEKES GENERAL CONTRACTING
LTD.
668237 WINMAR FRANCHISE CORP.
649369 WJC MAINTENANCE SERVICES LTD.
643092 WOODY’S AUCTIONS LIMITED

Companies Act

Loi sur les compagnies

Notice of decision to dissolve provincial companies
Take notice that the Director under the Companies Act has made a decision to dissolve the following companies pursuant to paragraph
35(1)(c) of the Act, as the said companies have been in default in sending to the Director fees, notices, and/or documents required by the Act.
Please note that 60 days after the date of publication of this Notice in
The Royal Gazette, the Director may dissolve the companies.

Avis d’une décision de dissoudre les compagnies provinciales
Soyez avisé que le Directeur, en application de la Loi sur les compagnies, a pris la décision de dissoudre les compagnies suivantes en vertu
de l’alinéa 35(1)c) de la Loi, puisque lesdites compagnies ont fait défaut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou documents requis par la Loi. Soyez avisé que 60 jours après la date de la publication
du présent avis dans la Gazette royale, le Directeur pourra dissoudre
lesdites compagnies.

022293 Association régionale de la communauté
francophone de Saint-Jean inc.
003081 CARLETON CURLING CLUB,
LIMITED.
024895 CARLETON MANOR FOUNDATION
INC.

003307 CENTRE COMMUNAUTAIRE
PAROISSE STE-CECILE SPORTS &
LOISIRS, INC.
021774 CODIAC VIKINGS AQUATIC CLUB
INCORPORATE CLUB AQUATIQUE
CODIAC VIKINGS INCORPOREE

025258 COMMISSION INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE DU GRAND
SHIPPAGAN INC.
004143 CONGREGATION SHAAREI-ZEDEK,
LIMITED
004182 CONSEIL RECREATIF DE STE.
MARIE INC.

The Royal Gazette — January 21, 2015

65

630071 Curryville Community Outreach Center
Inc.
668909 D.D Net Works Inc.
022530 DEJA VU/SECOND HAND CLOTHING
STORE INC.
025229 DEVELOPMENTAL SERVICES
(SAINT JOHN) INC.
025687 EATING DISORDER COUNCIL OF
NEW BRUNSWICK INC.
006298 FLORENCEVILLE CURLING CLUB,
LTD.
668270 Friends of Cameroon Inc.
668637 Grappe en Composites NB Inc. - NB
Composites Cluster Group Inc.
024137 HILLSBOROUGH KIWANIS
COMMUNITY CENTER, INC.
008545 IRISHTOWN COMMUNITY CENTRE
INC.
025834 JUDO NB INC.
623725 JUSTICE & EQUITY Inc.

Gazette royale — 21 janvier 2015

024560 KENNEBECASIS VALLEY HIGH
SCHOOL ACTIVITIES
COMMITTEE, INC.
024366 LAKEHEAD R.V. CLUB INC.
023321 LE MOUVEMENT SCOUTS ET
GUIDES DE DRUMMOND INC.
024332 LES POMPIERS DE SAINTE-ANNE DE
MADAWASKA INC.
662328 Lutte New Brunswick Wrestling Inc.
006783 Manufactured Housing Association of
Atlantic Canada Inc.
025840 Marathon by the Sea, Inc.
011544 MCADAM LIONS CLUB INC.
630099 Moncton Flyers Hockey Club Inc.
024361 MOUNTAINVIEW TRAILMAKERS
SNOWMOBILE CLUB INC.
024892 NASHWAAK WATERSHED
ASSOCIATION INC.
023605 PARTAGE & AMITIE INC.

Partnerships and Business
Names Registration Act
TAKE NOTICE that, pursuant to sections 12.3 and 12.31 of the Partnerships and Business Names Registration Act R.S.N.B., 1973, c. P-5,
the Registrar under the said Act intends to cancel the registration of the
certificates of partnership of the firms set forth in Schedule “A” annexed hereto and the certificates of business names of the businesses
set forth in Schedule “B” annexed hereto by reason of the fact the said
firms and businesses have failed to register certificates of renewal in
accordance with paragraph 3(1)(b) or (c) or subsection 3.1(2) or 9(7),
as the case may be applicable, of the said Act.
FURTHER TAKE NOTICE that at any time after the expiration date of
thirty (30) days from the date of publication of this Notice, the Registrar may cancel the registration of the said certificates of partnerships
and certificates of business names.

605525 PETTY TRAIL BLAZERS ATV CLUB
INC.
668820 Renewed Hope Church of God Ltd.
667489 Réseau d’inclusion communautaire de
Kent/Kent Community Inclusion
Network Inc.
636835 ROCKINGSTONE GARDEN HOMES
INC.
023328 SAINT JOHN ASSOCIATION FOR
COMMUNITY LIVING, INC.
668721 ST. JAMES COMMUNITY
FOUNDATION INC.
021533 ST. MARY’S CEMETERY LTD. CIMETIERE STE MARIE LTEE
022080 STICKNEY & AREA RECREATION
COUNCIL INC.
023333 THE JOHN HOWARD SOCIETY OF
FREDERICTON, INC.
016190 TIFERES ISRAEL LTD.

Loi sur l’enregistrement des
sociétés en nom collectif et
des appellations commerciales
SACHEZ QUE, conformément aux articles 12.3 et 12.31 de la Loi sur
l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, L.R.N.-B. de 1973, chap. P-5, le registraire a l’intention, en
vertu de ladite loi, d’annuler l’enregistrement des certificats de sociétés
en nom collectif indiquées à l’annexe « A » ci-jointe et des certificats
d’appellations commerciales des commerces indiqués à l’annexe « B »
ci-jointe, en raison du fait que ces firmes ou commerces ont négligé de
faire enregistrer des certificats de renouvellement conformément à
l’alinéa 3(1)b) ou c) ou au paragraphe 3.1(2) ou 9(7) de ladite loi, selon
le cas.
SACHEZ AUSSI qu’en tout temps après la date d’expiration de trente
(30) jours à partir de la date de publication du présent avis, le registraire
peut annuler l’enregistrement desdits certificats de sociétés en nom
collectif et certificats d’appellations commerciales.

Schedule “A” / Annexe « A »
Certificates of Partnerships / Certificats de sociétés en nom collectif
647510
609363
648462
647801
647817
647655
609496

Alward Brothers Farm
ANNCATH-ROBY CRAFTS
ATLANTIC CONCIERGE SERVICE
Canned Games
Cargojet Regional Partnership
COLOR GLO NEW BRUNSWICK
DREAM COTTAGE

646602
647479
648292
348062
647623
609418
647803

Dream Fitness
GAGNE ET CYR OPTOMETRISTES
Gower Exteriors
GRAHAM EXPORT SALES
Green Acres Estate
Kchikhusis Daycare
Le Petite-Chapeau

603570
647332
647525
345806
609550
647622

Les Moulures Lumar Mouldings
Maritime Spray Foam
SHERMTREV ENTERPRISES
Spacek & Norrad Chartered Accountants
Thornton Projects
V-Sure Enterprises

____________________________________________________

Schedule “B” / Annexe « B »
Certificates of Business names / Certificats d’appellations commerciales
647631
646899
615443
615225
647874

21st Century Resumes
878 Waterfront Bistro & Café
Acadie Trophy
ACE OF TRADES CONTRACTING
ADDICTION PSYCHIATRY AND
METHADONE CARE (MIRAMICHI)
REG’D.
609565 ADORABLE
608777 ADRIEN CHARPENTIER MENUISIER
609404 ADVANCED ADHESIVES

647786 ALBO’S BUILDING AND
RENOVATIONS
648182 ALL IN ONE MUSIC
647936 ANGEL CITY TATTOOS
648277 Aqua Blast Hot Tubs Sales & Service
615705 Arthur Ross A M Trucking
342857 Association des Bibliothécaires et
Professeur.e.s Retraités de l’Université
de Moncton
648468 ASTRO C. D. TRUCKING
647693 At Your Finger Tips-Est.2009

646968
609636
647723
609519
647759
647834
641616
647710
609300

ATLANTIC AIR AMBULANCE
Auberge Centre-Ville Enr.
AUBERGE PITOU EN VACANCE
AUDUBON ORGANICS
B&J CARPENTRY & GARDENING
B.W. Auto Cleaning Specialists
Balanced Viewpoint
Barry’s Discs
BASKET SHOPPE QUALITY
GOURMET GIFTS
647658 Bay of Fundy Shark Fishing Charters

The Royal Gazette — January 21, 2015
648174
609380
648330
647615
648117
647947
647941
647534
647897
647752
648298
647636
647503
647574
647924
647257
647271
647272
647270
648472
647721
647626
615488
310810
332553
647856
647733
615634
647504
647546
647547
647585
647582
647624
648401
615650
646727
647549
615391
648098
615403
615455
616358
647666
337759
648483

647505
609554
335044
615727
610164
615665
647506
647516
647572
615608
647701
322081
647772
609391
647511
647099
647888
647512
340679

Berry’s Auto & Recreation
Bertelsen Properties
BEST ALARMS
Beyond Bronz Tanning
BGP Technologies
Bolduc Forestry Services
Boost Research & Development
Bordertown Collision Centre
Boudreaus Bay AutoBody
BOUTIQUE 31
Brian McCulloch’s Small Engine Repair
Britta’s Bear Island Bed & Breakfast
Bronzage D’Azur
Buen Dia Canada
C.B. DeMerchant & Sons
CANACCORD ADAMS
CANACCORD CAPITAL
CANACCORD INSURANCE
SERVICES
CANACCORD WEALTH
MANAGEMENT
CANACCORD WEALTH
MANAGEMENT
CANARGY FOODS
Canuck Web Services
Capital Spring and Suspension
CARLETON-KIRK LODGE
CARTIER WINES & BEVERAGES
CBW Bookkeeping Services
CENTRE AUDITIF BEAUSÉJOUR
HEARING CENTER
Centre Dentaire Elmwood/Elmwood
Dental Centre
Charlotte County P.M.S. Property
Management Services
CITICORP HOME MORTGAGE
CITICORP HYPOTHÈQUES
RÉSIDENTIELLES
CLEAN VOLT ATLANTIC
Clinique l’Endodontie de Grand-Sault/
Grand Falls Endodontics Clinic
Clinique Myocare Clinic
Cobalt Crow Productions
Cogerno
Coiffure PraDá
Coldwell Banker Dynamic Realty
COLWELL SECURITY SYSTEMS
Cool Cat Creations
Corkum Photographics
Country Studio
Countrycatz
Coverdale Renovations
COX COMMUNICATIONS
CRC CONSULTANTS &
RÉPARATIONS CLINIQUE / CRC
CLINICAL REPAIRS &
CONSULTANTS
Creative Boss
CREDIT CONSEIL PLUS DU N B
CREDIT CONSULTANTS PLUS
OF N B
CURL’N COMB
D-micro Technology
D. ELLIS AUTO SALES
Danielle’s Lingerie
DAVE’S REFINISHING SERVICES
DAY & ROSS TRADE NETWORKS
Depanneur & Station Service Harricana
Dependable Auto Sales
Dixon Plumbing & Heating
DOBSON CHRYSLER DODGE
DOCTEUR GUM DOCTOR
DOOLY’S BLUE ROOM
DOWN EAST MOBILE WASH
Down the Lane Beauty Salon
Dr. Dish, Satellite TV Specialist
DT PIZZA
DUPMAG CONSULTATION

66
647653 EAST COAST PEOPLE’S CHOICE
AWARDS
648427 Eastern Paint Ball Supplies
647792 Easy Travel
647876 ECO - ART UNLIMITED
647804 Eco Clean
648314 Elm Creek Livestock Equipment
647917 Empire Stevedoring (Maritimes) Co.
647760 Enseignes Maximum Signs
615384 EXPLORE YOUR WORLD DAYCARE
647955 EXTREME DRIVEWAY SEALER
647565 Eye Shine Studio
615801 FCPC
648143 Fire & Ice Graphix
615591 First Organic Bakery
646494 Fitness Excellence Athletic Training
(FEAT)
647603 Flight Graphics and Design
615800 FOOD AND CONSUMER PRODUCTS
OF CANADA
647903 FOREVER YOUNG SPECIAL CARE
615592 Fournier & Associés Enr.
647575 Fredericton Mitsubishi
314185 FREDERICTON REALTY
648220 FRESH GROUND CAFE
647643 FRONTIER DIVING
647621 Fruit Sendsations
647755 Fundy Medical Supplies
647497 Future Dream Ventures
647814 GAIA DESIGNS
647629 GALLERY CONNEXION Organization
of the Development of Artists
647686 Garage Jacques Michaud
647802 Garderie La cour des grands
647642 GEMM Home Builders & Design
648358 Gentle Touch Footcare
615832 girvanmedia
615696 GLASSWERX NEON SIGNS
615576 Gordon Cowan Plumbing
609385 Grace Adventures
647782 Gray Wolf Photos
648166 GROVE HILL CONSULTING
647771 GUMWIZARD
647911 HARMONY HOUSE VENTURES
648217 Hartt Island RV Resort
609527 Heavenly Gowns Bridal Boutique &
Formal Wear
648168 Hennigar & Associates Consulting
615596 HI VENTURE FARMS
647614 HIGH FIVE Early Learning Centre
647514 Howe Technological Services
647532 IATC Marketing and Consulting
609719 ING Novex
648432 Integrity Investigations and Document
Service
647866 Intuitive Energy
647928 iSpark Creative Adventures
615840 J. F. Balcomb & Associates
647766 JETPAC Marketing Solutions
609616 JG Comeau & Associates
648207 Jill Little Design
615746 JKM Special Care Home
647315 Jmailer
647673 Joan & J Pet Styling
647651 JOLI Laser Aesthetics
345713 Juniper Construction
647871 K & D Property Maintenance
647865 KamDEN Graphics & Promotions
648093 KAMM-LAB
648094 KAMM-LAB MEDICAL
LABORATORY SERVICES
648150 Kelly’s Repair & Service Centre
648489 KEVIN’S GARAGE & TOWING
648491 KEVIN’S TRUCKING
609279 KFC
615631 Kim’s Hair Design
648141 Kimble Convenience
609447 KING STREET SPORTS

Gazette royale — 21 janvier 2015
647845 Kings Chapel Funeral Home & Cremation
Centre
648418 Kings Way LifeCare Alliance
647849 Kingsclear Construction
648297 Knots Be Gone Massage
648124 Know Fire Canada
337639 L’ACADIE NOUVELLE
647810 L’AUDACIEUSE CUISINE
648086 L5 Media
647698 La Mijoterie
647499 LA SPOT DES PÊCHEURS
647689 Le Centre de Soins au Palace
647634 Le Réseau des Échos du NouveauBrunswick
345823 LeeCom Enterprises
615793 Les Chalets-sur-Mer enrg.
647523 LIL’ NASHIRA MASSAGE
647915 Lise Gallant Bookkeeping Services
647763 Location Daniel Lepage Rental
615842 LONGHORN TRANSPORTATION
648184 Lydon Consulting
648433 Lynn’s Eyebrow Clinic
615770 M & B BLUEBERRY FARMS
647654 M D S WHOLESALERS
648296 M.R.M. Custom Woodwork
647397 MACONNERIE BEL ROC ENR
348233 MADILL’S REFRIGERATION & AIR
CONDITIONING
648177 Man Around the House Home
Renovations
648275 MAPPINS JEWELLERS
648187 Marc Gould Trucking
645792 mariages créAtioNIK weddings
648265 Maritime Mobile Dj Services
647372 Mary Lou’s Blood Collection Service
647854 MATTCAN TRANSPORT
647858 Max Income Tax
343176 MCVAN ENTERPRISES
648165 Merynic Consulting
647568 Michael Code Insurance
647558 Mighty Duct Cleaners
610169 Mill Cove Convenience
615618 Milled Rite Lumber
647798 MITCHELL HAYNES CONTRACTING
647741 MMMarvellous MMMuffins
647740 MMMuffins
648130 MONCTON PARK N SELL
647536 Mondrian
647537 Mondrian-Hall
647747 Monsieur Bibitte
647526 MORTON PUB
647907 MOUNT PLEASANT VILLAGE
648179 Mr. Movie
648096 MSR Marketing & Sales Agency
615643 Mukonda Canada Venture Partners
647594 My Work Site
331667 NBTel Mobile Office
331549 NBTel Mobility
331668 NBTel Optimizer
648142 Net Tech Solutions
648395 No Bells No Wall Learning - Apprendre
sans cloche sans mur
647674 Noella Fleuriste
648415 North End Auto Repair
615511 North Side Collision Miramichi
345745 NUSSEY CONSULTING
647608 OLD TIME CATERING
648149 One-Stop Electronics
648128 OX-BOW FARM
334903 P.W.F. TRANSPORTATION SERVICES
315925 PALADIN FINANCIAL SERVICES
648172 PC Home Canada
647581 PC Techworld
647580 PCTW Networking Group
647652 PEEL PUB
648270 PEOPLES JEWELLERS
335047 PETER DEMERCHANT GENERAL
CONSTRUCTION
641608 PHINNEY SALVAGE

The Royal Gazette — January 21, 2015
648329
609188
609277
647571
647628
647648
647600
648325
647680
615430
615732
647730
335072
609317
648266
615849
647314
647609
647944
648463
648206
648474
310815
332667
646254
615848
647553
609637
647939
609303
609267
647850
615223
648308

Phototropical by Valerie Biebuyck
Pine Glen Designs
Pizza Hut
PLATINUM PARKING
MANAGEMENT SYSTEMS
PMW Precision Machine Works
Prince Edward Guardian
PRINCESS BRIDE WEDDINGS
Pro Dent
PROMOTIONS BLANCHARD/
BLANCHARD PROMOTIONS
PS Consulting
QUINCY’S ELECTRIC
R & B Under The Red Roof
R M B TECH
RACHELLE’S CUTS & CREATIONS
RBG Consulting
Re/Max Hartford Realty
Red Door Smokin’ Supplies
REEDS POINT PUB & GRILL
Renar Animation
Repair Pro Auto
Résidence chêne de Mambré
RetroReplay
RITEWAY AUTO LEASING
ROBBIE O’NEILL ENTERPRISES
Robert Breau Ferme
Robin’s Inn
Roger’s No Frills
Rogersville Auto Salvage
S.T.A.R. SOUND THE ALARM
RECORDING STUDIO
Saint John College
SAINT JOHN LASER CLINIC
Salon Coiffure Centre-Ville
Salon Mexicut
Sammy’s Forest Management

67

Gazette royale — 21 janvier 2015

648420 SAPUTO DIVISION PRODUITS
LAITIERS (CANADA) / SAPUTO
DAIRY PRODUCTS DIVISION
(CANADA)
647682 Savi Jewelry
609612 Scierie BLT
647905 Sécurité Financière André Gallant
Financial Security
609417 Seeking Balance
646819 SELECT BEAUTY SUPPLIES
647808 Shediac Glass & Maintenance
610166 Shiretown Image Maker
647791 Sinderella’s Toy Box
647583 Sistema Canada
647584 Sistema New Brunswick
648089 Solar Smart Solutions
647855 South East Energy
348168 SPOTLESS JANITORIAL
609290 STUDENT TAXI
647586 SUE’S COUNTRY NOOK
646936 Swath Custom Cutlery Forge and
Rehoning
647891 SYNERGYSCREENS
609278 Taco Bell
648334 Tall Oaks Administrative Services
332604 THE AUCTION CENTER
648105 The Big Clean
648216 The Bucket Club Outdoor Activity Park
609333 The Buckley’s Company / la compagnie
Buckley
615509 the Computer Aided Bookkeeping
company
316198 THE GOODIE SHOP
647559 The Great Canadian Pub Lounge
300380 THE HILLTOP PUB
615822 THE SIDE BAR
648147 The Tin Can Convenience Store

648402
609349
648237
348114
647493
348135
647577
647646
647940
648309
608420
648208
648323
647599
609342
608735
615733
646985
648083
609448
647704
647968
647974
648261
615662
609435
609222
647859
647480
647495
647857
647690
609524

The Vintage Rose
Three Apples Arts and Crafts
TINA’S ISLAND MARKET
TOP DECK RESTAURANT
Top Flight Mortgage Centre
TOP OF THE TOWN
Torsten Linke Trucking
Total S.P.O.R.T. Centres
Totten Trucking
TRIMACK PROPERTY CARE
TRIUS TAXI
Twilight Night Club
Tycho Computers
TYTECH SOLUTIONS
V-GOLF
VCS COST MANAGEMENT
SOLUTIONS
VF CANADA
VIENNEAU QUALITY
MERCHANDISE
Vinny’s Chip Truck
Violette Dental Health
Vision Plus
VisionA Consultants
Viva Mode
Wall Property Services
WASHADEMOAK COMMUNITY
CALENDAR
Water Metrics
WEIR’S MACHINE SHOP
Windy Hollow Enterprises
WINTERWOOD NATURAL FOODS
WitsEye Publishing
WOODSIDE STABLE
Woodstock Main Street Convenience
WORKIN FOLK ART

Business Corporations Act

Loi sur les corporations
commerciales

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of incorporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de constitution en corporation a été émis à :

Registered Office
Bureau enregistré

Reference
Number
Numéro de
référence

Date
Year Month Day
année mois jour

DRE JOËLLE DROLET-FERGUSON C.P. INC.

Tracadie-Sheila

679937

2015

01

01

Elite 1 MMA Productions Inc.

Lakeville

679960

2014

12

15

Boutique Bébé tout neuf inc.

Haut-Lamèque

679983

2015

01

01

C. S. Technologies Group Inc.

Saint John

680038

2014

12

17

Reference marketing URLs Inc.

Saint John

680040

2014

12

17

GESTION PAUL LECLERC INC.

Grand-Sault / Grand Falls

680077

2015

01

01

Newmarket Forest Ventures Ltd.

Brockway

680079

2015

01

01

Dr. Louis Juravsky Professional Corporation

Moncton

680085

2015

01

01

680087 N.B. Inc.

Lutes Mountain

680087

2014

12

19

Pro Fuel Plus Ltd.

Caraquet

680093

2014

12

19

680094 NB INC.

Miramichi

680094

2014

12

19

Name / Raison sociale

The Royal Gazette — January 21, 2015

68

Gazette royale — 21 janvier 2015

THERRIEN FABRICATION INC.

Edmundston

680095

2014

12

19

680096 NB INC.

Miramichi

680096

2014

12

19

TLG Bookkeeping Services Inc.

Bathurst

680097

2014

12

19

K & R ELECTRICAL SERVICES INC.

Grande-Anse

680101

2014

12

22

Savarin Holdings Limited

Saint John

680102

2014

12

22

A.R. Léger Holdings Inc.

Moncton

680108

2014

12

22

680115 NB Inc.

Lepreau

680115

2014

12

22

680116 NB INC.

Saint-Léonard

680116

2014

12

22

Hutt Chiropractic Professional Corporation

Miramichi

680117

2014

12

22

Jackie A. Dableh-Hakimian CPA Professional Corporation

Fredericton

680119

2015

01

01

680122 N.B. LTD.

Douglas

680122

2014

12

22

M.J. Connors P.C. Incorporated

Fredericton

680125

2014

12

29

M.J. Connors Services P.C. Incorporated

Fredericton

680126

2014

12

29

680127 NB Ltd.

Dieppe

680127

2014

12

22

680128 NB Ltd.

Riverview

680128

2014

12

22

680129 N.B. Ltd.

Fredericton

680129

2014

12

22

AVG Consulting & Bookkeeping Ltd.

Moncton

680132

2014

12

22

MAPLE A.L. INC.

Saint-Quentin

680134

2014

12

22

Ego Modern Beauty Ltd.

Fredericton

680137

2014

12

22

A.W.O.L. BREWERY CORP.

Riverview

680138

2014

12

22

Liv9 Nutrition Inc.

Nackawic

680141

2014

12

22

680142 N.B. Inc.

Saint John

680142

2014

12

22

680144 NB INC.

Fredericton

680144

2014

12

23

680147 N.B. INC.

Miramichi

680147

2014

12

23

680148 N.B. Inc.

Moncton

680148

2014

12

23

Tough Guy Brewing Inc.

Fredericton

680149

2014

12

23

680150 NB INC.

Fredericton

680150

2014

12

23

680152 NB INC.

Sackville

680152

2014

12

23

680153 NB INC.

Sackville

680153

2014

12

23

680154 N.B. Ltd.

Sussex

680154

2014

12

23

GAR Holdings Inc.

Sackville

680160

2014

12

23

680161 N.B. Inc.

Fredericton

680161

2014

12

23

M. Chiasson P.C. Incorporated

Moncton

680162

2014

12

29

KPC Holdings Inc.

Sackville

680163

2014

12

23

M. Chiasson Services P.C. Incorporated

Moncton

680164

2014

12

29

BANKERS CAPITAL CANADA LTD.

Moncton

680165

2014

12

23

680166 NB Ltd.

Moncton

680166

2014

12

23

The Royal Gazette — January 21, 2015

69

Gazette royale — 21 janvier 2015

Dr. Vineeta Sethi P.C. Inc.

Fredericton

680167

2014

12

23

R.M. Boudreau P.C. Incorporated

Moncton

680174

2014

12

29

R.M. Boudreau Services P.C. Incorporated

Moncton

680176

2014

12

29

680177 NB Inc.

Monteagle

680177

2014

12

23

Jill Stairs Professional Corporation

Fredericton

680179

2014

12

23

Down East Window & Door Ltd.

Sussex

680180

2014

12

23

Bronzage Zana inc.

Kedgwick

680181

2014

12

23

680182 NB INC.

Campbellton

680182

2015

01

01

Corey’s Towing Ltd.

Petitcodiac

680183

2014

12

24

RONALD J. SAVOY PROFESSIONAL CORPORATION

Moncton

680184

2014

12

31

EMMY CHIASSON PROFESSIONAL CORPORATION

Moncton

680186

2014

12

31

Carrot Global Canada Limited

Fredericton

680189

2014

12

26

Seymour Holdings Ltd.

Fredericton

680200

2014

12

29

680211 NB LTD.

Grafton

680211

2014

12

29

Calumniam Consulting Inc.

Fredericton

680212

2014

12

29

680214 NB Ltd.

Moncton

680214

2014

12

29

680223 NB Inc.

Fredericton

680223

2014

12

30

Silver Mountain Targets Inc.

Keswick Ridge

680224

2014

12

30

Redgrey Consulting Inc.

Fredericton

680225

2014

12

30

ALDAN Holdings Inc.

Fredericton

680226

2014

12

30

680228 N.B. Inc.

Saint John

680228

2014

12

30

680236 NB Inc.

Fredericton

680236

2014

12

30

680237 NB Ltd.

Grand Bay-Westfield

680237

2014

12

30

Kaajenga Inc.

Moncton

680238

2014

12

30

Peter E. Crocco Professional Corporation

Woodstock

680239

2014

12

30

680240 N.B. INC.

Oak Bay

680240

2014

12

30

Advance Care Canada Limited

Rothesay

680247

2014

12

30

DARCY D & D HOLDING CO. LTD.

Keswick Ridge

680256

2014

12

31

Candle in the Window Primitives Inc.

Boiestown

680257

2014

12

31

Oak Haven Auto Renewal Ltd.

Oak Haven

680272

2014

12

31

Design Right Canada Ltd.

Saint John

680278

2015

01

01

D. Armstrong Professional Corporation

Fredericton

680279

2015

01

01

680280 NB Holdings (539474) Inc.

Fredericton

680280

2015

01

01

Dr. Jennifer Landry Professional Corporation

Saint John

680281

2014

12

31

680282 N.B. Ltd.

Saint John

680282

2014

12

31

MATTHEW G. DERRAH, CPA, CA PROFESSIONAL
CORPORATION

Woodstock

680284

2015

01

02

The Royal Gazette — January 21, 2015

70

Gazette royale — 21 janvier 2015

MICHAEL R. CORMIER P.C. INC.

Moncton

680287

2015

01

02

680295 NB Ltd.

Fredericton

680295

2015

01

02

NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUM
Business Corporations Act / Loi sur les corporations commerciales
In relation to a certificate of incorporation issued on December 15, 2014 under the name of “Premier Shuttle Inc.”, being corporation #679961,
notice is given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of incorporation correcting the name of the incorporator
from “Jean Dbé” to “Jean Dubé”.
Sachez que, relativement au certificat de constitution en corporation délivré le 15 décembre 2014 à « Premier Shuttle Inc. », dont le numéro de
corporation est 679961, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat d’incorporation corrigé faisant passer le nom du
fondateur de « Jean Dbé » à « Jean Dubé ».
_____________________________________________________
In relation to a certificate of incorporation issued on December 16, 2014 under the name of “Future Bridge Inc.”, being corporation #679984, notice
is given that pursuant to s. 189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of incorporation correcting the name of one of the directors
from “Sonh Trinh” to “Son Trinh” and also correcting the address of another director.
Sachez que, relativement au certificat de constitution en corporation délivré le 16 décembre 2014 à « Future Bridge Inc. », dont le numéro de corporation est 679984, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat d’incorporation corrigé faisant passer le nom d’un
des administrateurs de « Sonh Trinh » à « Son Trinh » et corrigeant aussi l’adresse d’un des autres administrateurs.
_____________________________________________________
In relation to a certificate of incorporation issued on December 16, 2014 under the name of “Prosharp Inc.”, being corporation #679985, notice is
given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of incorporation correcting the “Schedule – Other Provisions
/ Annexe – D’autres dispositions” to the attached articles.
Sachez que, relativement au certificat de constitution en corporation délivré le 16 décembre 2014 à « Prosharp Inc. », dont le numéro de corporation
est 679985, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat d’incorporation corrigé corrigeant le « Schedule – Other
Provisions / Annexe – D’autres dispositions » dans les articles ci-joints.
_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of continuance has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de prorogation a été émis à :
Previous
Jurisdiction
Compétence
antérieure

Reference
Number
Numéro de
référence

Date
Year Month Day
année mois jour

Name / Raison sociale

Registered Office
Bureau enregistré

MARITIME BERRIES LIMITED

Sackville

Nouvelle-Écosse /
Nova Scotia

680139

2014

12

22

IOC Oil Holdings Limited

Saint John

Ontario

680143

2014

12

22

MMC INSURANCE SERVICES LIMITED

Moncton

Nouvelle-Écosse /
Nova Scotia

680146

2014

12

19

_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of amendment has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de modification a été émis à :

Name / Raison sociale

Reference Number
Numéro de référence

Date
Year Month Day
année mois jour

BRIAN HARRIS INSURANCE LTD.

007810

2014

12

23

B. & A. YOUNG LTD.

010421

2014

12

22

QUALITY SOUND ALARM LTD.

013518

2014

12

22

The Royal Gazette — January 21, 2015

71

Gazette royale — 21 janvier 2015

COX’S HOLDINGS LTD.

031202

2014

12

29

BLUECORP INC.

038434

2014

12

29

040877 N.B. LTD.

040877

2014

12

29

ROGERSVILLE ARCTIC SPORTS LTD.

041261

2014

12

30

JAMCO CONTRACTING LTD.

041337

2014

12

22

JARDINE AUCTIONEERS INC.

046222

2014

12

30

PODOCO LTEE

047938

2014

12

22

K. & I. FOOD SERVICES LTD.

052237

2014

12

19

VOLUSIA ENTERPRISES INC.

055430

2014

12

19

MIKE START HOLDINGS INC.

057995

2014

12

22

SOUTHERN SANITATION LTD

502201

2014

12

31

PROFESSIONAL QUALITY ASSURANCE LTD.

505741

2014

12

22

507877 N.B. LTD.

507877

2014

12

23

Financial Foundations Inc.

509729

2014

12

23

I. & G. Food Services Ltd.

512895

2014

12

19

Maritime Communication Services (N.B.) Ltd.

513121

2014

12

22

J.M.L. Garage Ltée

604203

2014

12

22

Place Broadway Ltée - Broadway Place Ltd.

610146

2014

12

23

CORPORATION PROFESSIONNELLE DR. PAUL LECLERC INC.

621453

2015

01

01

TOSS Architecture Inc.

622523

2014

12

22

New River Holdings Inc.

629063

2014

12

23

BASEK Hurley Holdings Ltd.

630946

2014

12

23

634939 N.B. Inc.

634939

2014

12

19

635497 N.B. Inc.

635497

2014

12

23

635498 N.B. Inc.

635498

2014

12

23

ENERCHECK SOLUTIONS INC.

636777

2014

12

23

ESR INVESTMENTS INC.

640906

2015

01

02

Assurance Sylvio Leclerc Inc.

641245

2014

12

22

K. Watt & Associates Inc.

642897

2014

12

23

Moosehead Breweries Limited

643823

2014

12

23

JOEY’S PUB & EATERY INC.

645519

2014

12

19

PVC Home Builders Ltd.

650875

2014

12

22

663683 N.B. Inc./ 663683 N.-B. Inc.

663683

2014

12

31

North of Sixty Art Ltd.

667626

2014

12

24

New Steffeshof Farms 2013 Ltd.

670028

2014

12

23

Scheele Holding Ltd.

670030

2014

12

23

673969 NB Inc.

673969

2014

12

23

The Royal Gazette — January 21, 2015

72

Gazette royale — 21 janvier 2015

D. WHALEN CONSULTING FIRM INC.

676898

2014

12

23

680076 N.B. Inc.

680076

2014

12

23

NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUM
Business Corporations Act / Loi sur les corporations commerciales
In relation to a certificate of amendment issued on Dcember 22, 2014 under the name of “B. & A. YOUNG LTD.”, being corporation #010421,
notice is given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of amendment amending the “Schedule – Share Structure / Annexe – Organisation du capital social” to the attached articles.
Sachez que, relativement au certificat de modification délivré le 22 décembre 2014 à « B. & A. YOUNG LTD. », dont le numéro de corporation est
010421, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat corrigé de modification modifiant le « Schedule – Share Structure / Annexe – Organisation du capital social » dans les articles ci-joints.
_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of amendment which includes a change in
name has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de modification contenant un changement de raison
sociale a été émis à :

Name / Raison sociale

Previous name
Ancienne raison sociale

Reference Number
Numéro de référence

Date
Year Month Day
année mois jour

22 King Street Inc.

GILMAC MANAGEMENT LTD.

034221

2015

01

02

East Glassville Holdings Ltd.

Calvin D. Anderson & Son Inc.

046691

2014

12

29

Steeves Porter Hetu & Associates Inc.

DALE B. STEEVES PROFESSIONAL
CORPORATION

059037

2014

12

23

FITSTATS TECHNOLOGIES, INC.

ADVANCED FITNESS DESIGNS Inc

512670

2014

12

30

G. & S. Holdings Inc.

EXCEL Pest Control LTD.

512934

2014

12

31

Bluecorp (2015) Inc.

Bluecorp Realty Inc.

513252

2015

01

01

JMN ENTERPRISES INC.

ATELIER LANDRY INC.

513602

2014

12

23

514313 N.B. Inc.

Domaine Parlee Beach Inc.

514313

2015

01

01

TriStar Fine Cars Inc.

613735 NB INC.

613735

2015

01

01

M2 Project Builders Inc.

EcoTek Homes Ltd.

631710

2014

12

29

DLN Investments Inc.

Dr. Nidal Chami C.P. Inc.

650863

2014

12

22

B&J Auto Services Inc.

657565 N.B. LTD.

657565

2014

12

23

661352 N.B. LTD.

OLEARY BUICK GMC LTD.

661352

2014

12

22

UWI Holdings Corporation

Australian Sapphire Corporation

670570

2014

12

23

E STYLE PRO INC.

Nineteen E-Cigarette & Accessories Inc.

677433

2014

12

19

McDEL LANDSCAPING AND SNOW
REMOVAL CO. INC.

679321 NB Inc.

679321

2014

12

22

Shy Lady Fisheries Ltd.

679350 N.B. Ltd.

679350

2014

12

23

Hayoli Fisheries Ltd.

679359 N.B. Ltd.

679359

2014

12

29

EASTWIND BUSINESS SOLUTIONS INC.

FLAGSTAFF HOLDINGS INC.

679970

2015

01

01

Campbellton Hardware Inc.

MCO Holding Inc.

680133

2015

01

01

The Royal Gazette — January 21, 2015

73

Gazette royale — 21 janvier 2015

BelleBay Holdings Inc.

679710 N.B. Inc.

680159

2014

12

25

Harvey Insurance Ltd.

648490 NB Inc.

680199

2014

12

31

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of amalgamation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de fusion a été émis à :

Amalgamated Corporation
Corporation issue de la fusion

Amalgamating Corporations
Corporations fusionnantes

Registered Office
Bureau enregistré

Reference
Number
Numéro de
référence

Mirisa Holdings Inc.

Darrell J. Stephenson Professional
Corporation
D.J. Stephenson P.C. Inc.

Rothesay

679885

2015

01

01

Eastern Compactor Services Ltd.

PENNFIELD LOGGING LTD.
Eastern Compactor Services Ltd.

Lutes Mountain

679945

2015

01

01

Chaisson Lemoine Professional

Chaisson Lemoine Professional
Corporation
679214 N.B. Inc.

Saint John

679969

2014

12

31

FLAGSTAFF HOLDINGS INC.

Eastwind Business Solutions Inc.
FLAGSTAFF HOLDINGS INC.

Petitcodiac

679970

2015

01

01

ANDRITZ HYDRO CANADA INC.

Andritz Hydro Canada Inc.
Saint John
Andritz Hydro Ltée./Andritz Hydro Ltd.

680030

2015

01

01

ÉPICERIE LEBRETON (2014) LTÉE

Epicerie LeBreton 1998 Ltée
679605 NB INC.

Shippagan

680031

2014

12

31

649850 N.B. Ltd.

051536 N. B. LTD.
649850 N.B. Ltd.

Moncton

680044

2015

01

01

GENERAL FINANCIAL CORPORATION
LTD.

514313 N.B. Inc.
602867 N.B. LTD.
GENERAL FINANCIAL
CORPORATION LTD.

Shediac

680048

2015

01

01

Jean-Marc Gauvin C.P. Inc.

GO-20 INC.
059892 NB Inc.
Jean-Marc Gauvin C.P. Inc.

Saint-Simon

680068

2015

01

01

FPM HOLDING INC.

CLARENCE DAIGLE & FILS LTEE - Edmundston
CLARENCE DAIGLE & SONS LTD.
J.J. CONSTRUCTION & LEASING
CO. LTD.
FPM HOLDING INC.

680082

2015

01

01

MONCTON FISH MARKET LTD.

MONCTON FISH MARKET LTD.
629697 N.B. Inc.
629700 N.B. Inc.

Moncton

680083

2014

12

23

R. & D. ENTERPRISES LTD.

R. & D. ENTERPRISES LTD.
679835 NB INC.

Campbellton

680090

2015

01

01

Irving Consumer Products Limited
Les Produits de Consommation
Irving Limitée

Irving Tissue Corporation
Les Papiers Irving Incorporée
Irving Personal Care Limited
Les Soins Personnels Irving Limitée
Irving Consumer Products Limited
Les Produits de Consommation
Irving Limitée

Saint John

680104

2015

01

01

Coast Tire & Auto Service Ltd.

COAST TIRE (FAIRVILLE BLVD.)
LTD.
Coast Tire & Auto Service Ltd.

Saint John

680114

2015

01

01

Date
Year Month Day
année mois jour

The Royal Gazette — January 21, 2015

74

Gazette royale — 21 janvier 2015

MCO Holding Inc.

MCO HOLDING INC.
CAMPBELLTON HARDWARE INC.

Campbellton

680133

2015

01

01

LA CAUSERIE AMICALE INC.

Sunflower Patch Daycare Inc. /
Garderie Jardin de Tournesols Inc.
Friendship Circle DayCare Inc. /
Garderie Le Cercle d’Amitié Inc.
La Causerie Amicale Inc.

Cocagne

680135

2015

01

01

R & D Zinck Holdings Ltd.

501932 N.B. Inc.
R & D ZINCK HOLDINGS LTD.
CTB Holdings Ltd.
649103 N.B. Inc.

McLeod Hill

680140

2015

01

01

SNOKIST LTD.

PRYOR FARMS LTD.
SNOKIST LTD.

Hartford

680145

2015

01

01

679710 N.B. Inc.

BelleBay Holdings Inc.
679710 N.B. Inc.

Saint John

680159

2014

12

25

Family First Human Services Inc.

FAMILY FIRST HUMAN SERVICES
INC.
674027 N.B. Inc.

Richibucto Road

680168

2015

01

01

Matt Holdings Ltd.

M.F. ESSON & SONS, LIMITED
MATT HOLDINGS LTD.

Hanwell

680187

2015

01

01

Max Health Institute and
Physiotherapy P.C. Inc./
Institut de la santé Max et
physiothérapie c.p. inc.

MAX Health Institute Inc. /
Institut de santé Max inc.
Max Health Institute and
Physiotherapy P.C. Inc./
Institut de la santé Max et
physiothérapie c.p. inc.

Dieppe

680194

2015

01

01

ASSURANCE VIENNEAU LTEE VIENNEAU INSURANCE LTD.

ASSURANCE VIENNEAU LTEE VIENNEAU INSURANCE LTD.
Assurance Beauséjour Insurance
Ltée. - Assurance Beauséjour
Insurance Ltd.

Shediac

680195

2015

01

01

607198 N.B. LTD.

607198 N.B. LTD.
658229 N.B. INC.

Bethel

680198

2015

01

01

648490 NB Inc.

HARVEY INSURANCE LTD.
648490 NB Inc.

Harvey Station

680199

2014

12

31

Power Engineers Canada, Inc.

Power Food Consulting, Inc.
Power Engineers Canada, Inc.

Fredericton

680203

2015

01

01

C.J. Poirier Entreprises Ltée

PODOCO LTEE
C.J. POIRIER ENTREPRISES LTÉE

Grand-Barachois

680230

2015

01

01

SHEPODY BERRY & LUMBER,
CO. LTD.

SACKVILLE MEDICAL REALTIES Sackville
LTD.
SHEPODY BERRY & LUMBER, CO.,
LTD.
MARITIME BERRIES LIMITED

680231

2015

01

01

629856 N.B. Ltd.

629856 N.B. LTD.
654845 N.B. Ltd.
654847 N.B. Ltd.

Moncton

680232

2014

12

31

Scan Air Balance (1998) Ltd.

Scan Air Balance (1998) Ltd.
661252 NB LTD.

Moncton

680233

2015

01

01

David McCarthy Ltd.

DAVID MCCARTHY LTD.
Ebbett Farms Limited

Upper Kent

680234

2015

01

01

On The Trail Adventures Ltd.

Northway Outfitters Ltd.
On The Trail Adventures Ltd.

Windsor

680235

2015

01

01

The Royal Gazette — January 21, 2015

75

Gazette royale — 21 janvier 2015

BACK BAY SALMON LTD.

BACK BAY SEA URCHINS LTD.
BACK BAY SALMON LTD.

Back Bay

680244

2015

01

01

Xplornet Communications Inc.

Xplornet Broadband Inc.
632527 New Brunswick Inc.
Xplornet Communications Inc.

Woodstock

680246

2015

01

01

Lounsbury Company Limited

Lucien LeBlanc Holdings Inc.
Lounsbury Company Limited

Moncton

680250

2015

01

01

Lounsbury Company Limited

C. H. S. Holdings Inc.
Lounsbury Company Limited

Moncton

680251

2015

01

01

New Brunswick EMS Inc.

BLUECORP INC.
New Brunswick EMS Inc.
MMC INSURANCE SERVICES
LIMITED

Moncton

680253

2015

01

01

CRESCENT (1952) LIMITED

CRESCENT (1952) LIMITED
667090 NB LTD.

Hartland

680254

2015

01

01

Omer LeBlanc & Son Ltd./Ltée

OMER LEBLANC & SON LTD/LTEE Dalhousie
MARITIME ROOF SYSTEMS LTD./
SYSTEME DE TOIT MARITIME
LTEE.

680260

2015

01

01

HOWLAND HOLDINGS LTD.

HOWLAND HOLDINGS LTD.
BELLEISLE LEASING LTD.

Quispamsis

680262

2014

12

31

Charles & Marthe Investments Inc.

Pharmacie Richard Pharmacy Inc.
Charles & Marthe Investments Inc.

Saint-Louis-deKent

680263

2015

01

01

G. Lemieux & A. Ménard P.C. Inc.

J. Gilles Lemieux Corporation
Professionnelle Inc./ Professional
Corporation
Alison J. Ménard P.C. Inc.

Saint-Antoine

680264

2015

01

01

CFMO Company Limited

CFMO Company Limited
CFME Company Limited
IOC Oil Holdings Limited

Saint John

680266

2015

01

01

Brett Chevrolet Cadillac Buick

058928 N.B. INC.
Brett Chevrolet Cadillac Buick GMC
Ltd.

Saint John

680269

2015

01

01

056632 N.B. LTD.

056632 N.B. LTD.
Saint John Auto Auction Ltd.
653760 N.B. INC.
661765 N.B. Ltd.

Rusagonis

680270

2015

01

01

Briggs & Little Woolen Mills Ltd.

BRIGGS & LITTLE WOOLEN MILLS Harvey
LTD.
JOHN LITTLE HOLDINGS LTD.

680271

2015

01

01

Restigouche Court Development Inc.

RESTIGOUCHE COURT
DEVELOPMENT INC.
Maximum Paving Inc.

Campbellton

680274

2015

01

01

Meubles J.R. Lagacé Inc.

Meubles J.R. Lagacé Inc.
MEUBLES EKO FURNITURE INC.

Campbellton

680276

2015

01

01

RIJON INVESTMENTS LTD.

RIJON INVESTMENTS LTD.
JONRI MANAGEMENT LTD.

Saint John

680285

2015

01

02

_____________________________________________________

The Royal Gazette — January 21, 2015

76

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of dissolution has been issued to:

Gazette royale — 21 janvier 2015
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de dissolution a été émis à :

Registered Office
Bureau enregistré

Reference
Number
Numéro de
référence

Date
Year Month Day
année mois jour

COASTAL CANADA PETROLEUM, INC.
PETROLE COASTAL CANADA, INC.

Saint John

057264

2014

12

19

Sterling Electronic Commerce (Canada), Inc./
Commerce Electronique Sterling (Canada) Inc.

Saint John

608455

2014

12

30

Dollarama Corporation

Saint John

615595

2014

12

18

W. E. P. Edwards Consulting Solutions Inc.

Saint John

636383

2014

12

29

R.A. Soucy Consultants Inc.

Edmundston

638626

2014

12

19

JOHNSTON’S TOWING & RECOVERY INC.

Sussex Corner

644060

2014

12

31

Apex Tool Holding Canada 3 Ltd.

Saint John

651136

2014

12

31

Dre Nadine Kabwe Kiti C.P. Inc.

Edmundston

659435

2014

12

19

Name / Raison sociale

_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a restated certificate of incorporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de constitution mise à jour a été émis à :

Name / Raison sociale

T.M.M. Fabrication Inc.

Reference Number
Numéro de référence

Date
Year Month Day
année mois jour

047026

2014

12

22

_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, notice of the discharge of a receiver or a receivermanager of the following corporations has been received:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un avis de libération d’un séquestre ou séquestre-gérant pour les
sociétés suivantes a été reçu :

Name / Raison sociale

Registered Office
Bureau enregistré

Receiver or
Receiver-Manager
Séquestre ou
séquestre-gérant

Reference
Number
Numéro de
référence

Date
Year Month Day
année mois jour

Pneus ABC Tires Inc.

Atholville

POWELL ASSOCIATES LTD.

621674

2014

12

22

_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of discontinuance has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de cessation a été émis à :

Name / Raison sociale

Jurisdiction of Continuance
Compétence de prorogation

Reference Number
Numéro de référence

Date
Year Month Day
année mois jour

Distribution 83 PPM Inc.

Québec / Quebec

514356

2014

12

22

THE NIGHT SHIFT ANSWERING SERVICE
LTD.

Colombie-Britannique /
British Columbia

626338

2014

12

12

PT Health NB Professional Corporation

Canada

662997

2014

12

11

_____________________________________________________

The Royal Gazette — January 21, 2015

77

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of revival has been issued to:

Gazette royale — 21 janvier 2015
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de reconstitution a été émis à :

Name / Raison sociale

Reference Number
Numéro de référence

Date
Year Month Day
année mois jour

BILL A’COURT SALES LTD.

501819

2014

12

22

Hugh Investment Group Corporation

611487

2014

12

23

Ray of Light Daycare Inc.

660606

2014

12

22

_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of registration of extra-provincial corporation
has been issued to:

Name / Raison sociale

Jurisdiction
Compétence

ANDREW ROBERTS PROFESSIONAL Canada
CORPORATION LTD.

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat d’enregistrement de corporation extraprovinciale a été
émis à :

Agent and Address
Représentant et adresse

Andrew D.W. Roberts
Moncton

Reference
Number
Numéro de
référence

Date
Year Month Day
année mois jour

680045

2014

12

18

ALTIUS RESOURCES INC.

Terre-Neuve et Labrador/ McInnes Cooper
Newfoundland and
CSD Services Inc.
Labrador
Fredericton

680103

2014

12

19

Escalade Wines & Spirits Inc.

Ontario

Stewart McKelvey Corporate
Services (NB) Inc.
Saint John

680113

2014

12

22

9108483 Canada Inc.

Canada

Donald J. Stevenson
Fredericton

680130

2014

12

22

Fjallraven USA, LLC

New York

Stewart McKelvey Corporate
Services (NB) Inc.
Saint John

680156

2014

12

23

9122800 Canada Inc.

Canada

Trevor Cookson
Fredericton

680178

2014

12

23

GGR Finance Inc.

Ontario

Jay Phinney
Saint John

680196

2014

12

29

Eckler Ltd./Eckler ltée

Ontario

Arthur T. Doyle
Saint John

680197

2014

12

29

ENTREPRISES JOCELYNE FAUVEL
INC.

Canada

Jocelyne Fauvel
Pointe-Alexandre

680204

2014

12

29

9116869 Canada Corporation

Canada

René Basque
Moncton

680210

2014

12

29

_____________________________________________________

The Royal Gazette — January 21, 2015

78

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of amendment of registration of extraprovincial corporation has been issued to:

Gazette royale — 21 janvier 2015
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de modification de l’enregistrement de corporation
extraprovinciale a été émis à :

Name / Raison sociale

Previous name
Ancienne raison sociale

Reference
Number
Numéro de
référence

Date
Year Month Day
année mois jour

IRI-Aztec (Canada) Ltd.

Aztec Information Services (Canada) Limited

672195

2014

12

23

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of registration of amalgamated corporation
has been issued to the following extra-provincial corporations:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat d’enregistrement d’une corporation extraprovinciale
issue de la fusion a été émis aux corporations extraprovinciales suivantes :
Agent and Address
Représentant et
adresse

Reference
Number
Numéro de
référence

Date
Year Month Day
année mois jour

Amalgamated Corporation
Corporation issue de la fusion

Amalgamating Corporations
Corporations fusionnantes

MGA Partners Inc.

MGA Partners Inc.

Stewart McKelvey
Corporate Services
(NB) Inc.
Saint John

680022

2014

12

17

MGA Partners Inc.

MGA Partners Inc.

Stewart McKelvey
Corporate Services
(NB) Inc.
Saint John

680023

2014

12

17

SLEEMAN BREWERIES LTD./
BRASSERIE SLEEMAN LTEE

SLEEMAN BREWERIES LTD.
BRASSERIE SLEEMAN LTEE

Willard M. Jenkins
Saint John

680220

2014

12

29

Companies Act

Loi sur les compagnies

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,
letters patent have been granted to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres
patentes ont été émises à :

Name / Raison sociale

Head Office
Siège social

Reference
Number
Numéro de
référence

Date
Year Month Day
année mois jour

Santélo Inc.

Edmundston

680089

2014

12

19

FRIENDS OF KENNEBECASIS VALLEY LIBRARY INC.

Quispamsis

680172

2014

12

23

The Royal Gazette — January 21, 2015

79

Gazette royale — 21 janvier 2015

Partnerships and Business Names
Registration Act

Loi sur l’enregistrement des
sociétés en nom collectif et des
appellations commerciales

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and
Business Names Registration Act, a certificate of business name has
been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en
nom collectif et des appellations commerciales, un certificat d’appellation commerciale a été enregistré :

Registrant of
Certificate
Enregistreur
du certificat

Address of Business
or Agent
Adresse du commerce ou
du représentant

Reference
Number
Numéro de
référence

Date
Year Month Day
année mois jour

Crafts Trucking

Thomas M. Craft

Saint John

679532

2014

11

19

Matrix North American
Construction

Matrix SME Canada ULC

Saint John

679954

2015

01

01

You-Mist-It Vape Store

Sophia Macleod

Moncton

679976

2014

12

16

Vacation Express Canada

Sunwing Vacations Inc./
Vacances Sunwing Inc.

Saint John

680000

2014

12

17

The Blake Wealth Management
Group

Dundee Securities Ltd./
Valeurs Mobilieres Dundee ltee

Saint John

680007

2014

12

17

Forgeron Régis Haché

Régis Haché

Losier Settlement

680033

2014

12

17

SMS Ventilation

Shirley Morin

Saint-Joseph

680035

2014

12

29

Inn Thyme Lodging

678836 NB Inc.

Shediac

680046

2014

12

18

Auberge Inn Thyme

678836 NB Inc.

Shediac

680047

2014

12

18

Atlantic Quality & Technical
Services

Atlantic Quality & Technical
Services Inc.
Les Services Techniques & De
Qualité Atlantiques Inc.

Saint John

680062

2014

12

18

SYNERGY DESIGNS

GRAYSIA WEB SITE DESIGN
AND VIRTUAL ASSISTANT
SERVICES INC.

Sussex

680063

2014

12

18

Signature Pre-Owned Auto
Gallery

045502 N. B. LTD.

Saint John

680065

2014

12

18

Maritime Oysters N.B.

M.R. JAILLET ENTERPRISES
INC.

Saint-Joseph-de-Kent

680066

2014

12

18

Doctor’s Orders:
Rehabilitation Canes

676855 New Brunswick Inc.

Fredericton

680067

2014

12

18

Andrew C Electric

Heather Long

Riverview

680075

2014

12

18

DOYEN TECHNICAL

Pragmantis Group Inc.

Saint John

680091

2014

12

19

PATRICK RICHARDS
PHOTOGRAPHY

Pragmantis Group Inc.

Saint John

680092

2014

12

19

Kira M Painting

Kira McLean

Fredericton

680098

2014

12

20

Chaleur Shamrock East/West
Applications

Ray Ed Dawson

Dalhousie

680099

2014

12

20

HughGarse FoodTruck

Kevin Robert

Salisbury

680100

2014

12

20

Les Produits de Consommation
Irving

Irving Consumer Products
Limited Les Produits de
Consommation Irving Limitée

Dieppe

680105

2015

01

01

Name / Raison sociale

The Royal Gazette — January 21, 2015

80

Gazette royale — 21 janvier 2015

Irving Consumer Products

Irving Consumer Products
Limited Les Produits de
Consommation Irving Limitée

Dieppe

680106

2015

01

01

Les Soins Personnels Irving

Irving Consumer Products
Limited Les Produits de
Consommation Irving Limitée

Dieppe

680107

2015

01

01

Irving Personal Care

Irving Consumer Products
Limited Les Produits de
Consommation Irving Limitée

Dieppe

680109

2015

01

01

Laqua Holdings

Stephan Laqua

Saint-Edouard-de-Kent

680118

2014

12

22

Jesters Tactical Sports Center

Nathan Den Hollander

Lincoln

680120

2014

12

22

Craft General Contracting

Thomas Craft

Saint John

680121

2014

12

22

Courtside Sneakers

9108483 Canada Inc.

Fredericton

680131

2014

12

22

TOWNE AUTO CENTER

Towne Sales and Service
Limited

Napan

680136

2014

12

22

Kelly L. Buffett Law Office

Kelly Buffett

Fredericton

680151

2014

12

23

Fredericton Hyundai

679604 N.B. Ltd.

Fredericton

680157

2014

12

23

OLeary Buick GMC

679603 N.B. Ltd.

Fredericton

680158

2014

12

23

Ashford Auto Body

Rodney Ashford

Berry Mills

680175

2014

12

23

Evergreen Traders

Trevor Rivett

Fredericton

680185

2014

12

24

Dooly’s Sports Bar II

505342 N.B. LTD.

Fredericton

680190

2014

12

29

Your Ideal Weigh

677858 N.B. Corp.

Fredericton

680206

2014

12

29

CR Yardworks & Equipment

Brandon Cox

Riverview

680217

2014

12

29

Costello’s Plumbing & Heating

Derrick Costello

Miramichi

680219

2015

01

01

STROH BREWERY

SLEEMAN BREWERIES LTD./
BRASSERIE SLEEMAN LTEE

Saint John

680221

2014

12

29

SLEEMAN UNIBROUE

SLEEMAN BREWERIES LTD./
BRASSERIE SLEEMAN LTEE

Saint John

680222

2014

12

29

Rodolphe Monette Psychologue

Rodolphe Monette

Dieppe

680241

2014

12

31

IMB Apparel

Sajid Butt

Quispamsis

680255

2014

12

31

Lemieux Ménard & Co.

G. Lemieux & A. Ménard P.C.
Inc.

Saint-Antoine

680265

2015

01

01

FANCY COFFEE SERVICES

Frederick A. Dixon

Florenceville-Bristol

680273

2014

12

23

Maximum Paving

Restigouche Court
Development Inc.

Campbellton

680275

2015

01

01

Meubles EKO Furniture

Meubles J.R. Lagacé Inc.

Atholville

680277

2015

01

01

Ironstone Enterprises

Bradley Gillcash

Dundas

680283

2015

01

02

The Royal Gazette — January 21, 2015

81

Gazette royale — 21 janvier 2015

NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUM
Partnerships and Business Names Registration Act / Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales
In relation to the certificate of business name registered on December 14, 2014 under the Act, under the name of “The Urban Nest Gifts & Decor”,
being file #679948, notice is given that pursuant to s.17 of the Act, the Registrar has ordered that the address at section 6 be corrected to read as
follows: “Douglastown Plaza, 3 Renaud Street, Miramichi, NB”.
Sachez que, relativement à un certificat d’appellation commerciale enregistré le 14 décembre 2014 en vertu de la Loi sous le nom de « The Urban
Nest Gifts & Decor », dont le numéro d’appellation commerciale est 679948, le registraire a ordonné, conformément à l’article 17 de la Loi, que
l’adresse à la section 6 soit corrigée pour qu’elle se lise comme suit : « Douglastown Plaza, 3 Renaud Street, Miramichi, NB ».
_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and
Business Names Registration Act, a certificate of renewal of business
name has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en
nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de renouvellement d’appellation commerciale a été enregistré :

Name / Raison sociale

Registrant of
Certificate
Enregistreur
du certificat

Address of Business
or Agent
Adresse du commerce ou
du représentant

Reference
Number
Numéro de
référence

Date
Year Month Day
année mois jour

MOUNTAIN MAPLES

Leslie C. Stiles

Elgin

319142

2015

01

01

SLEEMAN BREWING & MALTING SLEEMAN BREWERIES LTD./
CO.
BRASSERIE SLEEMAN LTEE

Saint John

347657

2014

12

29

STROH CANADA

SLEEMAN BREWERIES LTD./
BRASSERIE SLEEMAN LTEE

Saint John

347762

2014

12

29

IRVING TISSUE

Irving Consumer Products
Limited Les Produits de
Consommation Irving Limitée

Dieppe

350888

2015

01

01

IRVING TISSUE COMPANY

Irving Consumer Products
Limited Les Produits de
Consommation Irving Limitée

Saint John

350889

2015

01

01

Sussex Towing

504741 N.B. LTD.

Passekeag

609318

2014

12

19

Les Papiers Irving

Irving Consumer Products
Limited Les Produits de
Consommation Irving Limitée

Dieppe

609364

2015

01

01

GNR Sales & Service

Gabriel Cormier

Irishtown

610248

2014

12

17

VALLEY CLEANERS

Mark Wayne Hovey

Valley Road

610511

2014

12

18

Jessica Rhaye Music

Jessica Grimmer

Hampton

610521

2014

12

18

DEWITT LINGUISTIC SERVICES

Steven Dewitt

Fredericton

610552

2014

12

22

SLEEMAN MARITIMES

SLEEMAN BREWERIES LTD./
BRASSERIE SLEEMAN LTEE

Saint John

611699

2014

12

29

Fireball Gallery & Studio

D. Lynne Bowland

Lord’s Cove

615858

2014

12

27

BEAULIEU ALUMINIUM

GROUPE DEAN DAIGLE
GROUP INC.

Edmundston

616026

2014

12

23

RED BULL BEER COMPANY

SLEEMAN BREWERIES LTD./
BRASSERIE SLEEMAN LTEE

Saint John

622350

2014

12

29

Roy Auto St-Quentin

Joël Roy

Saint-Quentin

629980

2014

12

30

Ecole DansEncorps School

Chantal Cadieux

Moncton

645712

2014

12

22

Around the Block Contracting

Michael Parker

Weldon

646445

2014

12

19

JONES GALLERY

Sarah Jones

Saint John

647031

2014

12

30

The Royal Gazette — January 21, 2015

82

Gazette royale — 21 janvier 2015

Le Festival de Canneberge du
Canada Atlantique

Village de Rogersville

Rogersville

647032

2014

12

23

Festival de la Récolte Canneberge
à Rogersville

Village de Rogersville

Rogersville

647033

2014

12

23

Célébration de la Récolte des
canneberges

Village de Rogersville

Rogersville

647034

2014

12

23

Capital City Toy Store

645062 NB Inc.

Hanwell

647121

2014

12

19

The Raven’s Tree Natural Body
Soaps & Creams

Ramona Leduc

Rusagonis

647756

2014

12

24

DON’S AUTO REPAIR AND
SERVICE

Donald LeBlanc

Memramcook

648044

2014

12

29

COLES

INDIGO BOOKS & MUSIC INC. Fredericton

648050

2014

12

16

Sodexo Services Canada

Sodexo Canada Ltd.

Saint John

648998

2014

12

22

STEP UP FOR LIFE

MONCTON CRISIS
PREGNANCY
CENTRE, INC.

Moncton

649373

2014

12

18

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and
Business Names Registration Act, a certificate of cessation of business or use of business name has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en
nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessation de l’activité ou de cessation d’emploi de l’appellation commerciale a été enregistré :
Address /
Adresse

Reference
Number
Numéro de
référence

Date
Year Month Day
année mois jour

STEEVES PORTER HE’TU

Rothesay

348564

2014

12

23

Fredericton Hyundai

Fredericton

609638

2014

12

22

TRI STAR FINE CARS

Saint John

614095

2015

01

01

B&J AUTO SERVICES

Dalhousie

621293

2014

12

23

Fancy Coffee Services

Riverbank

622072

2014

12

23

THERRIEN FABRICATION

Edmundston

625768

2014

12

23

HOLIDAY RESTAURANT

Cambridge-Narrows

627900

2014

12

18

Down East Window & Door

Sussex

643902

2014

12

23

Candle in the window primitives

Boiestown

655654

2014

12

31

O’LEARY AUTO GROUP

Fredericton

664093

2014

12

22

Boutique Bébé tout neuf

Tracadie-Sheila

664577

2014

12

31

Your Ideal Weigh

Fredericton

667771

2014

12

29

Design Right Canada

Saint John

674790

2015

01

01

A.W.O.L. Brewery

Riverview

675208

2014

12

22

Newmarket Forest Ventures

Newmarket

675713

2014

12

31

Bronsage ZANA

Kedgwick

679406

2014

12

23

Name / Raison sociale

The Royal Gazette — January 21, 2015

83

Gazette royale — 21 janvier 2015

D.S. Forma-Soins

Edmundston

679734

2014

12

18

The Urban Nest Gifts & Decor

Miramichi

679948

2014

12

29

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and
Business Names Registration Act, a certificate of change of agent for
service has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en
nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de changement d’un représentant pour fin de signification a été déposé :

Agent and Address /
Représentant et adresse

Name / Raison sociale

Indigo

Michael Connors
Fredericton

Reference
Number
Numéro de
référence

Date
Year Month Day
année mois jour

638727

2014

12

16

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and
Business Names Registration Act, a certificate of partnership has
been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en
nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de société en nom collectif a été enregistré :
Address of Business
or Agent
Adresse du commerce
ou du représentant

Reference
Number
Numéro de
référence

Date
Year Month Day
année mois jour

Name / Raison sociale

Partners / Membres

East Coast Beef Jerky

Tracey Johnston
Randy Johnston

Sackville

679870

2014

12

19

D.S. Forma-Soins

Sylvie Gaumont
Denis Chouinard

Edmundston

680060

2014

12

18

The Urban Nest Gifts & Decor

Laura St. Coeur
Wade St. Coeur

Miramichi

680191

2014

12

29

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and
Business Names Registration Act, a certificate of renewal of partnership has been registered:

Name / Raison sociale

CROSSFIT SAINT JOHN

Partners / Membres

Michael Jackson
Amy Wilkins

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en
nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de renouvellement de société en nom collectif a été enregistré :
Address of
Business or Agent
Adresse du
commerce ou
du représentant

Reference
Number
Numéro de
référence

Date
Year Month Day
année mois jour

Saint John

646912

2014

_____________________________________________________

12

18

The Royal Gazette — January 21, 2015

84

Gazette royale — 21 janvier 2015

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and
Business Names Registration Act, a certificate of dissolution of partnership has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en
nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de dissolution de société en nom collectif a été enregistré :
Address /
Adresse

Reference
Number
Numéro de
référence

Date
Year Month Day
année mois jour

Lemieux Ménard & Co.

Saint-Antoine

666665

2014

12

31

J and R Cleaning Service

Fredericton

676965

2014

12

31

Name / Raison sociale

Limited Partnership Act

Loi sur les sociétés en commandite

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partnership Act, a declaration of limited partnership has been filed by:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une
déclaration de société en commandite a été déposée par :

Name / Raison sociale

General Partners
Commandités

Principal place in
New Brunswick
Principal établissement au
Nouveau-Brunswick

Reference
Number
Numéro de
référence

Date
Year Month Day
année mois jour

ENBRIDGE GAS NEW BRUNSWICK
LIMITED PARTNERSHIP

Enbridge Gas New
Brunswick Inc./
Enbridge Gaz NouveauBrunswick

Fredericton

400538

2014

12

22

Agartis LP

Tortora, Julien F.R.

Saint John

680173

2014

12

23

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partnership Act, a declaration of extra-provincial limited partnership has
been filed:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une
déclaration de société en commandite extraprovinciale a été déposée par :

Principal place in
New Brunswick
Principal établissement au
Nouveau-Brunswick

Reference
Number
Numéro de
référence

Jurisdiction
Compétence

Date
Year Month Day
année mois jour

Trimac Transportation Services
Limited Partnership

Saint John

Alberta

Stewart McKelvey
Corporate Services
(NB) Inc.
Saint John

616032

2014

12

22

DOLLARAMA L.P. -DOLLARAMA
S.E.C.

Saint John

Québec / Quebec Stewart McKelvey
Corporate Services
(NB) Inc.
Saint John

616403

2014

12

17

Marketwired Holding L.P.

Saint John

Manitoba

Stewart McKelvey
Corporate Services
(NB) Inc.
Saint John

675396

2014

12

23

Marketwired L.P.

Saint John

Ontario

Stewart McKelvey
Corporate Services
(NB) Inc.
Saint John

680155

2014

12

23

Name / Raison sociale

Agent and Address
Représentant
et adresse

_____________________________________________________

The Royal Gazette — January 21, 2015

85

Gazette royale — 21 janvier 2015

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partnership Act, a declaration of extra-provincial limited partnership,
which includes a name change, has been filed:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une
déclaration de société en commandite extraprovinciale, contenant
une nouvelle raison sociale, a été déposée par :

Name / Raison sociale

Previous Name
Ancienne raison sociale

Jurisdiction
Compétence

Marketwired Holding L.P.

Marketwire L.P.

Manitoba

Agent and Address
Représentant
et adresse

Stewart McKelvey
Corporate Services
(NB) Inc.
Saint John

Reference
Number
Numéro de
référence

Date
Year Month Day
année mois jour

675396

2014

12

23

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partnership Act, a declaration of withdrawal of extra-provincial limited
partnership has been filed:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une
déclaration de retrait de société en commandite extraprovinciale a
été déposée par :
Agent and Address
Représentant
et adresse

Jurisdiction
Compétence

Name / Raison sociale

MARRET HIGH GRADE HEDGE LIMITED Ontario
PARTNERSHIP

Stewart McKelvey Corporate
Services (NB) Inc.
Saint John

Reference
Number
Numéro de
référence

Date
Year Month Day
année mois jour

648101

2014

12

24

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partnership Act, a declaration of change of limited partnership or extraprovincial limited partnership has been filed:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une
déclaration de changement de société en commandite ou de société
en commandite extraprovinciale a été déposée :

Name / Raison sociale

Jurisdiction
Compétence

General Partners
Commandités

Marketwired Holding L.P.

Ontario

Marketwired Canada
Limited

Principal place in
New Brunswick
Principal établissement au
Nouveau-Brunswick

Reference
Number
Numéro de
référence

Date
Year Month Day
année mois jour

Saint John

675396

2014

12

23

Department of Transportation
and Infrastructure

Ministère des Transports
et de l’Infrastructure

NOTICE OF SALE FOR REMOVAL
Camp
Lot 1
Black Top Mountain Group
Off Charlo Road, Black Top Mountain
Restigouche County, N.B.
One storey camp on Lot 1, Black Top Mountain Group, off
Charlo Road, Black Top Mountain, Restigouche County, N.B.
For inspection, contact Natural Resources’ Campbellton Office,
at 506-789-2336. Refer to Tender No. 15-L0045 on all communications. A property value of $500 has been placed on this
asset.

AVIS DE VENTE ET D’ENLÈVEMENT
Camp
Lot 1
Groupe du Mont Black Top
En retrait du chemin Charlo, Black Top Mountain
Comté de Restigouche (N.-B.)
Camp d’un étage situé sur lot 1, groupe du Mont Black Top, en
retrait du chemin Charlo, Black Top Mountain, comté de
Restigouche (N.-B.). Pour l’inspection, communiquer avec le
bureau du ministère des Ressources naturelles de Campbellton,
au 506-789-2336. Mentionner l’appel d’offres no 15-L0045
dans toutes les communications. La valeur du bien est de 500 $.

The Royal Gazette — January 21, 2015

86

Gazette royale — 21 janvier 2015

The purchaser may within 14 days from the date of receiving a
bill of sale, make application to the Department of Natural Resources for a recreational camp lot lease.

Dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception de
l’acte de vente, l’acheteur peut faire une demande au ministère
des Ressources naturelles pour un bail de lieu de camp.

Property Value: $500
Closing Date: January 26, 2015

Valeur du bien : 500 $
Date de fermeture : le 26 janvier 2015

For tender submission criteria,
Visit: www.GNB.ca/2221
Call: 506-453-2221
E-mail: pearl.black@gnb.ca
Reference: Tender No.: 15-L0045

Pour les conditions de soumission :
http://www.gnb.ca/2221/index-f.asp
Appeler : 506-453-2221
Par courriel : pearl.black@gnb.ca
Mentionner : l’appel d’offres no 15-L0045

Hon. Roger Melanson
Minister of Transportation and Infrastructure

Le ministre des Transports et de l’Infrastructure
L’Hon. Roger Melanson

Notices of Sale

Avis de vente

Sale of Lands Publication Act
R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)
To: Wendell Philip Morris, original Mortgagor and owner of the
equity of redemption; and to all others whom it may concern.
Sale pursuant to terms of the mortgage and the Property Act,
R.S.N.B. 1973, c.P-19, as amended. Freehold property situate at
104 Islandview Drive, Miramichi, in the County of Northumberland and Province of New Brunswick, and being identified
as PID 40220915.
Notice of Sale given by The Toronto-Dominion Bank, Mortgagee and holder of the mortgage. Sale to be held at the
Miramichi Law Courts, 673 King George Highway, Miramichi,
New Brunswick on Thursday, January 29, 2015, at the hour of
11:00 a.m., local time. See advertisement of Notice of Mortgage
Sale in the Miramichi Leader dated December 31, 2014, January 7, January 14, and January 21, 2015.

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces
L.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2)
Destinataire : Wendell Philip Morris, débiteur hypothécaire originaire et propriétaire du droit de rachat; et tout autre intéressé
éventuel. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte
d’hypothèque et de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19.
Biens en tenure libre situés au 104, promenade Islandview, à
Miramichi, comté de Northumberland, province du NouveauBrunswick, et ayant le NID 40220915.
Avis de vente donné par la Banque Toronto-Dominion, créancière hypothécaire et titulaire de l’hypothèque. La vente aura
lieu le jeudi 29 janvier 2015, à 11 h, heure locale, au palais de
justice de Miramichi, 673, route King George, Miramichi
(Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions
du 31 décembre 2014 et des 7, 14 et 21 janvier 2015 du
Miramichi Leader.

McInnes Cooper, Solicitors for The Toronto-Dominion Bank,
Per: Natalie M. Stewart, Suite 1700, Brunswick Square,
1 Germain Street, P.O. Box 6370, Saint John, New Brunswick,
E2L 4R8, Telephone: 506-643-6500, Facsimile: 506-643-6505

Natalie M. Stewart, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la
Banque Toronto-Dominion, Brunswick Square, bureau 1700,
1, rue Germain, C.P. 6370, Saint John (Nouveau-Brunswick)
E2L 4R8; téléphone : 506-643-6500; télécopieur : 506-643-6505

________________

________________

TO: NANCY DOREEN McKAY, of 128 Demille Court,
Hampton, New Brunswick, E5N 2E4, Mortgagor;

DESTINATAIRES : NANCY DOREEN McKAY, du
128, cour Demille, à Hampton (Nouveau-Brunswick),
E5N 2E4, débitrice hypothécaire;
BANQUE ROYALE DU CANADA, 100, rue King, Saint
John (Nouveau-Brunswick) E2L 1G4, créancière hypothécaire;
ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.
Lieux en tenure libre situés au 50-54, rue Waterloo, à Saint
John (Nouveau-Brunswick), paroisse de Saint John, comté de
Saint John, province du Nouveau-Brunswick, dont le NID est
13847.
Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulaire
de la première hypothèque.

AND TO: ROYAL BANK OF CANADA, 100 King Street,
Saint John, New Brunswick, E2L 1G4, Mortgagee;
AND TO: ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN.
Freehold premises situate, lying and being at 50-54 Waterloo
Street, Saint John, New Brunswick, in the Parish of Saint John,
County of Saint John, and Province of New Brunswick, also
known as PID 13847.
Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of the
first mortgage.

The Royal Gazette — January 21, 2015

87

Gazette royale — 21 janvier 2015

Sale on the 19th day of February, 2015, at 11:00 a.m., at the
Saint John County Registry Office at 2nd Floor, 15 King Square
North, Saint John, New Brunswick. The Mortgagee reserves the
right to postpone or reschedule the time and date of sale. See advertisement in the Telegraph-Journal.

La vente aura lieu le 19 février 2015, à 11 h, au bureau de l’enregistrement du comté de Saint John situé au 15, King Square
Nord, 2e étage, Saint John (Nouveau-Brunswick). La créancière
hypothécaire se réserve le droit de reporter la date et l’heure de
la vente. Voir l’annonce publiée dans le Telegraph-Journal.

Cox & Palmer, Solicitors for the Mortgagee, the Royal Bank of
Canada

Cox & Palmer, avocats de la créancière hypothécaire, la Banque
Royale du Canada

________________

________________

TO: NANCY DOREEN McKAY, of 128 Demille Court,
Hampton, New Brunswick, E5N 2E4, Mortgagor;

DESTINATAIRES : NANCY DOREEN McKAY, du
128, cour Demille, à Hampton (Nouveau-Brunswick),
E5N 2E4, débitrice hypothécaire;
BANQUE ROYALE DU CANADA, 100, rue King, Saint
John (Nouveau-Brunswick) E2L 1G4, créancière hypothécaire;
ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.
Lieux en tenure libre situés au 50-54, rue Wright, à Saint John
(Nouveau-Brunswick), paroisse de Saint John, comté de Saint
John, province du Nouveau-Brunswick, dont le NID est
55197511.
Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulaire
de la première hypothèque.
La vente aura lieu le 19 février 2015, à 11 h 15, au bureau de
l’enregistrement du comté de Saint John situé au 15, King
Square Nord, 2e étage, Saint John (Nouveau-Brunswick). La
créancière hypothécaire se réserve le droit de reporter la date et
l’heure de la vente. Voir l’annonce publiée dans le TelegraphJournal.

AND TO: ROYAL BANK OF CANADA, 100 King Street,
Saint John, New Brunswick, E2L 1G4, Mortgagee;
AND TO: ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN.
Freehold premises situate, lying and being at 50-54 Wright
Street, Saint John, New Brunswick, in the Parish of Saint John,
County of Saint John, and Province of New Brunswick, also
known as PID 55197511.
Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of the
first mortgage.
Sale on the 19th day of February, 2015, at 11:15 a.m., at the
Saint John County Registry Office at 2nd Floor, 15 King Square
North, Saint John, New Brunswick. The Mortgagee reserves the
right to postpone or reschedule the time and date of sale. See advertisement in the Telegraph-Journal.
Cox & Palmer, Solicitors for the Mortgagee, the Royal Bank of
Canada

Cox & Palmer, avocats de la créancière hypothécaire, la Banque
Royale du Canada

________________

________________

TO: NANCY DOREEN McKAY, of 128 Demille Court,
Hampton, New Brunswick, E5N 2E4, Mortgagor;

DESTINATAIRES : NANCY DOREEN McKAY, du
128, cour Demille, à Hampton (Nouveau-Brunswick),
E5N 2E4, débitrice hypothécaire;
BANQUE ROYALE DU CANADA, 100, rue King, Saint
John (Nouveau-Brunswick) E2L 1G4, créancière hypothécaire;
ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.
Lieux en tenure libre situés au 102, rue Carleton, à Saint John
(Nouveau-Brunswick), paroisse de Saint John, comté de Saint
John, province du Nouveau-Brunswick, dont le NID est 38133.

AND TO: ROYAL BANK OF CANADA, 100 King Street,
Saint John, New Brunswick, E2L 1G4, Mortgagee;
AND TO: ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN.
Freehold premises situate, lying and being at 102 Carleton
Street, Saint John, New Brunswick, in the Parish of Saint John,
County of Saint John, and Province of New Brunswick, also
known as PID 38133.
Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of the
first mortgage.
Sale on the 19th day of February, 2015, at 11:30 a.m., at the
Saint John County Registry Office at 2nd Floor, 15 King Square
North, Saint John, New Brunswick. The Mortgagee reserves the
right to postpone or reschedule the time and date of sale. See advertisement in the Telegraph-Journal.

Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulaire
de la première hypothèque.
La vente aura lieu le 19 février 2015, à 11 h 30, au bureau de
l’enregistrement du comté de Saint John situé au 15, King
Square Nord, 2e étage, Saint John (Nouveau-Brunswick). La
créancière hypothécaire se réserve le droit de reporter la date et
l’heure de la vente. Voir l’annonce publiée dans le TelegraphJournal.

Cox & Palmer, Solicitors for the Mortgagee, the Royal Bank of
Canada

Cox & Palmer, avocats de la créancière hypothécaire, la Banque
Royale du Canada

________________

________________

The Royal Gazette — January 21, 2015

88

Gazette royale — 21 janvier 2015

609508 NB INC., of 270 Orleans Street, Dieppe, New
Brunswick, E1A 5E2, Mortgagor; JOSEPH MICHEL
WILLIAM COMEAU, of 270 Orleans Street, Dieppe, New
Brunswick, E1A 5E2, Guarantor; TRESCO HOLDINGS
INC., Mortgagee and present holder of the First Mortgage; and
to all others to whom it in any way may concern. Notice of Sale
given by TRESCO HOLDINGS INC., the Mortgagee and
present holder of the First Mortgage. Freehold lands situate at
53 Water Street, Campbellton, Parish of Addington, County of
Restigouche and Province of New Brunswick. Sale on Monday,
the 16th day of February, A.D., 2015, at the hour of 11:00
o’clock in the forenoon, at or near the main entrance to the
County Court House, located at the City Centre Mall, Suite 202,
157 Water Street, P.O. Box 5001, Campbellton, in the County of
Restigouche, and Province of New Brunswick.
SEE ADVERTISEMENT IN THE TRIBUNE.

609508 NB INC., du 270, rue Orléans, Dieppe (NouveauBrunswick), E1A 5E2, débitrice hypothécaire; JOSEPH
MICHEL WILLIAM COMEAU, du 270, rue Orléans,
Dieppe (Nouveau-Brunswick), E1A 5E2, garant; TRESCO
HOLDINGS INC., créancière hypothécaire et titulaire actuelle
de la première hypothèque; et tout autre intéressé éventuel. Avis
de vente donné par TRESCO HOLDINGS INC., créancière
hypothécaire et titulaire actuelle de la première hypothèque.
Terrains en tenure libre situés au 53, rue Water, à Campbellton,
paroisse d’Addington, comté de Restigouche, province du
Nouveau-Brunswick. La vente aura lieu le lundi 16 février
2015, à 11 h, dans l’entrée principale du palais de justice du
comté, ou tout près, situé au Mall Centre-Ville, 157, rue Water,
bureau 202, C.P. 5001, Campbellton, comté de Restigouche,
province du Nouveau-Brunswick.
VOIR L’ANNONCE PUBLIÉE DANS THE TRIBUNE.

CYRIL C. SUTHERLAND, SOLICITOR FOR THE
FIRST MORTGAGEE: TRESCO HOLDINGS INC.

CYRIL C. SUTHERLAND, AVOCAT DE LA PREMIÈRE
CRÉANCIÈRE HYPOTHÉCAIRE, TRESCO HOLDINGS INC.

________________

________________

PROVINCE OF NEW BRUNSWICK
COUNTY OF CHARLOTTE

PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
COMTÉ DE CHARLOTTE

NOTICE OF SALE
TO: CLARENCE EDWARD GIBSON & DEBORAH ANN
GIBSON, Owners of the Equity of Redemption and Original
Mortgagors; GARY GIBSON, Guarantor; BHM FINANCIAL
GROUP, Judgment Creditor; and to all others whom it may
concern.
NOTICE IS HEREBY GIVEN under and by virtue of the provisions of the Property Act, being Chapter P-19, R.S.N.B., 1973
and amendments thereto and by virtue of the provisions contained in a certain Indenture of Mortgage bearing date the 17th
day of January, 2012 and registered in the Charlotte County
Land Titles Office on the 18th day of January, 2012 as Number
31071567 and made between CLARENCE EDWARD
GIBSON & DEBORAH ANN GIBSON, as Mortgagor and
GARY GIBSON, as Guarantor and WILLOWRICH INVESTMENT FUND, as Mortgagee, there will, for the purpose of obtaining payment of monies secured by the said Indenture of
Mortgage, default having been made in the payment thereof, be
sold at public auction at Service New Brunswick, 93 Milltown
Boulevard, St. Stephen, New Brunswick, on 10th day of February, 2015, at the hour of eleven o’clock (11:00 a.m.) in the forenoon, local time:
PID #15060221 – being property located at 132 Route 725,
Little Ridge, New Brunswick and 134 Route 725, Little
Ridge, New Brunswick
TOGETHER WITH all buildings and improvements thereon
and the rights, privileges and appurtenances to the same belonging.
AND FURTHER TAKE NOTICE that if a sufficient offer of
purchase is not received for the said lands and premise at such
public auction, the same may be withdrawn from such sale and
disposed of by private contract without further notice being
given.

AVIS DE VENTE
DESTINATAIRES : CLARENCE EDWARD GIBSON ET
DEBORAH ANN GIBSON, propriétaires du droit de rachat et
débiteurs hypothécaires; GARY GIBSON, garant; BHM FINANCIAL GROUP, créancier sur jugement; et tout autre intéressé éventuel.
AVIS est par les présentes donné conformément aux dispositions de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19, et en vertu
des dispositions contenues dans l’acte d’hypothèque établi le
17 janvier 2012 et enregistré au bureau de l’enregistrement foncier du comté de Charlotte le 18 janvier 2012, sous le numéro
31071567, entre CLARENCE EDWARD GIBSON ET
DEBORAH ANN GIBSON, débiteurs hypothécaires, et GARY
GIBSON, garant, et WILLOWRICH INVESTMENT FUND,
créancière hypothécaire, que seront vendus aux enchères publiques en vue d’acquitter les sommes garanties par ledit acte
d’hypothèque, étant donné le défaut d’en effectuer le paiement,
à Services Nouveau-Brunswick, 93, boulevard Milltown,
St. Stephen (Nouveau-Brunswick), le 10 février 2015, à 11 h,
heure locale :
le NID 15060221, correspondant aux biens situés au
132, route 725, Little Ridge (Nouveau-Brunswick) et au
134, route 725, Little Ridge (Nouveau-Brunswick)
AINSI QUE tous les bâtiments qui s’y trouvent et les améliorations qui y ont été apportées, ainsi que les droits, les privilèges
et les dépendances qui s’y rattachent.
SACHEZ AUSSI qu’à défaut de recevoir une offre d’achat suffisante pour lesdits terrains et bâtiments dans le cadre de la
vente aux enchères publique, ceux-ci pourraient être retirés de
la vente et vendus par contrat privé sans autre avis.

The Royal Gazette — January 21, 2015

89

Gazette royale — 21 janvier 2015

DATED at Woodstock, New Brunswick, this 7th day of January,
2015.

FAIT à Woodstock, au Nouveau-Brunswick, le 7 janvier 2015.

WILLOWRICH INVESTMENT FUND

WILLOWRICH INVESTMENT FUND

PETER A. BREWER, Solicitor for Willowrich Investment
Fund, Brewer Law Offices, 4-113 Broadway, Woodstock, NB
E7M 6B4, 506-325-2220

PETER A. BREWER, avocat de Willowrich Investment Fund,
Brewer Law Offices, 4-113, rue Broadway, Woodstock
(Nouveau-Brunswick) E7M 6B4, 506-325-2220

________________

________________

Sale of Lands Publication Act
R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)
To: Line Anne Gallant Hebert and Claude Hebert, original
Mortgagors; and to all others whom it may concern. Sale pursuant to terms of the Mortgage and the Property Act R.S.N.B.,
1973, c.P-19 and Acts in amendment thereof. Freehold property
being situated at 896 Walden Street, Miramichi, New
Brunswick, the same lot conveyed to Line Anne Gallant Hebert
and Claude Hebert by Transfer registered in the Land Titles
System on May 4, 2012, as document number 31427835.
Notice of Sale given by Bank of Nova Scotia as Mortgagee.
Sale to be held at or near the front of the Court House for the
Judicial District of Miramichi, 673 King George Highway,
Miramichi, New Brunswick on the 13th day of February, 2015,
at the hour of 11:00 a.m., local time. See advertisement of Notice of Sale in the Miramichi Leader dated January 14, January
21, January 28 and February 4, 2015.

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces
L.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2)
Destinataires : Line Anne Gallant Hebert et Claude Hebert, débiteurs hypothécaires originaires; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973,
c.P-19. Biens en tenure libre situés au 896, rue Walden, à
Miramichi (Nouveau-Brunswick), correspondant au même lot
ayant été transféré à Line Anne Gallant Hebert et Claude Hebert
par l’acte de transfert enregistré dans le système d’enregistrement foncier le 4 mai 2012, sous le numéro 31427835.
Avis de vente donné par la Banque de Nouvelle-Écosse, créancière hypothécaire. La vente aura lieu le 13 février 2015, à 11 h,
heure locale, devant le palais de justice de la circonscription judiciaire de Miramichi, ou tout près, 673, route King George,
Miramichi (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans
les éditions des 14, 21 et 28 janvier et du 4 février 2015 du
Miramichi Leader.

McInnes Cooper, Solicitors for Bank of Nova Scotia, Per: Adel
Gönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400, P.O.
Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6, Telephone:
506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095

Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Banque
de Nouvelle-Écosse, Centre de la Croix Bleue, bureau S400,
644, rue Main, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick)
E1C 8T6; téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095

________________

________________

TO: SHERRY DAWN SPENCER and THE ESTATE OF
VINCENT RUSSELL SPENCER, Mortgagors;

DESTINATAIRES : SHERRY DAWN SPENCER et LA
SUCCESSION DE VINCENT RUSSELL SPENCER, débiteurs hypothécaires;
ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.
Vente effectuée en vertu des dispositions du premier acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973,
c.P-19, art.44. Biens en tenure libre situés au 42, rue Labelle, à
Moncton, comté de Westmorland, province du NouveauBrunswick, et dont le numéro d’identification parcellaire est
70387360.
Avis de vente donné par SERVICES DE FINANCEMENT TD
RÉSIDENTIEL INC.
La vente aura lieu le jeudi 12 février 2015, à 11 h 15, à l’hôtel
de ville de Moncton, 655, rue Main, Moncton (NouveauBrunswick).
Voir l’annonce publiée dans les éditions des 14, 21 et 28 janvier
et du 4 février 2015 du Times & Transcript.

AND TO: ALL OTHERS TO WHOM IT MAY CONCERN.
Sale conducted under the terms of the first mortgage under the
Property Act, R.S.N.B., 1973, c.P-19, s.44 as amended. Freehold property situate at 42 Labelle Street, Moncton, Westmorland County, Province of New Brunswick and known as Parcel
Identifier Number 70387360.
Notice of Sale is given by TD FINANCING SERVICES
HOME INC.
The sale is scheduled for Thursday, February 12, 2015, at 11:15
a.m., at the Moncton City Hall, 655 Main Street, Moncton, New
Brunswick.
See advertisements in the Times & Transcript in the issues of
January 14, January 21, January 28, and February 4, 2015.
TD FINANCING SERVICES HOME INC., By: LAWSON
CREAMER, Per: Veronica L. Ford, Solicitors for the TD Financing Services Home Inc.

Veronica L. Ford, du cabinet LAWSON CREAMER, avocats de Services de financement TD résidentiel Inc.

________________

________________

The Royal Gazette — January 21, 2015

TO: MARIE JEANNE DUPLESSIS, also known as
JEANNE M. DUPLESSIS, and MOISE DUPLESSIS, Mortgagors;
AND TO: ALL OTHERS TO WHOM IT MAY CONCERN.
Sale conducted under the terms of the first mortgage under the
Property Act, R.S.N.B., 1973, c.P-19, s.44 as amended. Freehold property situate at 234 Weisner Road, LakevilleWestmorland, Westmorland County, Province of New
Brunswick and known as Parcel Identifier Number 70202528.
Notice of Sale is given by TD FINANCING SERVICES
HOME INC.
The sale is scheduled for Thursday, February 12, 2015, at 11:00
a.m., at the Moncton City Hall, 655 Main Street, Moncton, New
Brunswick.
See advertisements in the Times & Transcript in the issues of
January 14, January 21, January 28, and February 4, 2015.

90

Gazette royale — 21 janvier 2015

DESTINATAIRES : MARIE JEANNE DUPLESSIS, également connue sous le nom de JEANNE M. DUPLESSIS et
MOISE DUPLESSIS, débiteurs hypothécaires;
ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.
Vente effectuée en vertu des dispositions du premier acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973,
c.P-19, art.44. Biens en tenure libre situés au 234, chemin
Weisner, à Lakeville, comté de Westmorland, province du
Nouveau-Brunswick, et dont le numéro d’identification parcellaire est 70202528.
Avis de vente donné par SERVICES DE FINANCEMENT TD
RÉSIDENTIEL INC.
La vente aura lieu le jeudi 12 février 2015, à 11 h, à l’hôtel de
ville de Moncton, 655, rue Main, Moncton (NouveauBrunswick).
Voir l’annonce publiée dans les éditions des 14, 21 et 28 janvier
et du 4 février 2015 du Times & Transcript.

TD FINANCING SERVICES HOME INC., By: LAWSON
CREAMER, Per: Veronica L. Ford, Solicitors for the TD Financing Services Home Inc.

Veronica L. Ford, du cabinet LAWSON CREAMER, avocats de Services de financement TD résidentiel inc.

________________

________________

Sale of Lands Publication Act
R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)
To: Chantale Lorraine Humble and Dale Charles Humble, original Mortgagors; and to all others whom it may concern. Sale
pursuant to terms of the Mortgage and the Property Act
R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts in amendment thereof. Freehold property being situated at 181 Graveyard Hill, Stanley,
New Brunswick, the same lot conveyed to Chantale Lorraine
Humble and Dale Charles Humble by Transfer registered in the
Land Titles System on March 28, 2008, as document number
25348336.

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces
L.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2)
Destinataires : Chantale Lorraine Humble et Dale Charles
Humble, débiteurs hypothécaires; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973,
c.P-19. Biens en tenure libre situés au 181, Graveyard Hill, à
Stanley (Nouveau-Brunswick), et correspondant au même lot
ayant été transféré à Chantale Lorraine Humble et Dale Charles
Humble par l’acte de transfert enregistré dans le système d’enregistrement foncier le 28 mars 2008, sous le numéro
25348336.
Avis de vente donné par la Société hypothécaire Scotia, créancière hypothécaire. La vente aura lieu le 12 février 2015, à 11 h,
heure locale, au palais de justice de Fredericton, 427, rue
Queen, Fredericton (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des 14, 21 et 28 janvier et du 4 février
2015 du Daily Gleaner.

Notice of Sale given by Scotia Mortgage Corporation as Mortgagee. Sale to be held at the Fredericton Justice Building located at 427 Queen Street, Fredericton, New Brunswick on the
12th day of February, 2015, at the hour of 11:00 a.m., local time.
See advertisement of Notice of Mortgage Sale in The Daily
Gleaner dated January 14, January 21, January 28 and February
4, 2015.
McInnes Cooper, Solicitors for Scotia Mortgage Corporation,
Per: Adel Gönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite
S400, P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6,
Telephone: 506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095

Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Société
hypothécaire Scotia, Centre de la Croix Bleue, bureau S400,
644, rue Main, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick)
E1C 8T6; téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095

________________

________________

Sale of Lands Publication Act
R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)
To: Timothy Ryan Turner, original Mortgagor; and to all others
whom it may concern. Sale pursuant to terms of the Mortgage
and the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts in amendment thereof. Freehold property being situated at 2395 Route
845, Bayswater, New Brunswick, the same lot conveyed to
Timothy Ryan Turner by Transfer registered in the Land Titles
System on April 3, 2006, as document number 21908984.

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces
L.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2)
Destinataire : Timothy Ryan Turner, débiteur hypothécaire originaire; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée en vertu
des dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur
les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenure libre situés au
2395, route 845, à Bayswater (Nouveau-Brunswick), et correspondant au même lot ayant été transféré à Timothy Ryan Turner
par l’acte de transfert enregistré dans le système d’enregistrement foncier le 3 avril 2006, sous le numéro 21908984.

The Royal Gazette — January 21, 2015

91

Gazette royale — 21 janvier 2015

Notice of Sale given by HSBC Bank Canada as Mortgagee. Sale
to be held at the Saint John Provincial Building located at
10 Peel Plaza, Saint John, New Brunswick on the 12th day of
February, 2015, at the hour of 11:00 a.m., local time. See advertisement of Notice of Mortgage Sale in the Telegraph-Journal
dated January 14, January 21, January 28 and February 4, 2015.

Avis de vente donné par la Banque HSBC Canada, créancière
hypothécaire. La vente aura lieu le 12 février 2015, à 11 h,
heure locale, à l’édifice provincial de Saint John, situé au
10, place Peel, Saint John (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des 14, 21 et 28 janvier et du
4 février 2015 du Telegraph-Journal.

McInnes Cooper, Solicitors for HSBC Bank Canada, Per: Tony
S. Richardson, Barker House, Suite 600, 570 Queen Street, P.O.
Box 610, Station A, Fredericton, New Brunswick, E3B 5A6,
Telephone: 506-458-8572, Facsimile: 506-458-9903

Tony S. Richardson, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la
Banque HSBC Canada, Barker House, bureau 600, 570, rue
Queen, C.P. 610, succursale A, Fredericton (NouveauBrunswick) E3B 5A6; téléphone : 506-458-8572; télécopieur :
506-458-9903

Notice to Advertisers

Avis aux annonceurs

The Royal Gazette is published every Wednesday under the
authority of the Queen’s Printer Act. Documents must be received by the Royal Gazette Coordinator, Legislative
Services, no later than noon, at least seven days prior to
Wednesday’s publication. Each document must be separate
from the covering letter. Signatures on documents must be immediately followed by the printed name. The Royal Gazette
Coordinator may refuse to publish a document if any part of it
is illegible, and may delay publication of any document for administrative reasons.
Prepayment is required for the publication of all documents.
Standard documents have the following set fees:

La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformément à la Loi sur l’Imprimeur de la Reine. Les documents à
publier doivent parvenir à la coordonnatrice de la Gazette
royale, aux Services législatifs, à midi, au moins sept jours
avant le mercredi de publication. Chaque avis doit être séparé
de la lettre d’envoi. Les noms des signataires doivent suivre
immédiatement la signature. La coordonnatrice de la Gazette
royale peut refuser de publier un avis dont une partie est illisible et retarder la publication d’un avis pour des raisons administratives.
Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis.
Voici les tarifs pour les avis courants :

Notices
Notice of the intention to apply for the enactment of a
private bill
Originating process
Order of a court
Notice under the Absconding Debtors Act
Notice under the General Rules under the Law Society Act,
1996, of disbarment or suspension or of application for
reinstatement or readmission

Cost per
Insertion
$ 20
$
$
$
$

25
25
20
20

Notice of examination under the Licensed Practical Nurses
Act
Notice under the Motor Carrier Act
Any document under the Political Process Financing Act

$ 25

Notice to creditors under New Brunswick Regulation 84-9
under the Probate Court Act

$ 20

Notice under Rule 70 of the Rules of Court

$120

$ 30
$ 20

Coût par
parution

Avis
Avis d’intention de demander l’adoption d’un projet de loi
d’intérêt privé
Acte introductif d’instance
Ordonnance rendue par une cour
Avis exigé par la Loi sur les débiteurs en fuite
Avis de radiation ou de suspension ou de demande de
réintégration ou de réadmission, exigé par les Règles
générales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur le
Barreau
Avis d’examen exigé par la Loi sur les infirmières et
infirmiers auxiliaires autorisés
Avis exigé par la Loi sur les transports routiers
Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur le
financement de l’activité politique
Avis aux créanciers exigé par le Règlement du NouveauBrunswick 84-9 établi en vertu de la Loi sur la Cour des
successions
Avis exigé par la Règle 70 des Règles de procédure

20 $
25 $
25 $
20 $
20 $

25 $
30 $
20 $
20 $
120 $

Nota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 po
sur 14 po

Note: Survey Maps cannot exceed 8.5″ x 14″

Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is
1/2 page in length or less

$ 20

Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is
greater than 1/2 page in length

$ 75

Any document under the Winding-up and Restructuring Act
(Canada)

$ 20

Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voie
d’annonces, si l’avis est d’une demi-page ou moins en
longueur
Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voie
d’annonces, si l’avis est de plus d’une demi-page en
longueur
Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur les
liquidations et les restructurations (Canada)

20 $
75 $
20 $

The Royal Gazette — January 21, 2015

92

Gazette royale — 21 janvier 2015

Notice of a correction

charge is
the same as
for publishing
the original
document

Avis d’une correction

Any other document

$3.50 for each
cm or less

Tout autre document

les frais sont
les mêmes que
ceux imposés
pour la
publication du
document
original
3,50 $ pour
chaque cm ou
moins

Payments can be made by cash, MasterCard, VISA, cheque or
money order (payable to the Minister of Finance). No refunds
will be issued for cancellations.

Les paiements peuvent être faits en espèces, par carte de
crédit MasterCard ou VISA, ou par chèque ou mandat (à
l’ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement ne
sera effectué en cas d’annulation.

The official version of The Royal Gazette is available free
on-line each Wednesday. This free on-line service replaces the
printed annual subscription service. The Royal Gazette can be
accessed on-line at:

La version officielle de la Gazette royale est disponible gratuitement et en ligne chaque mercredi. Ce service gratuit en
ligne remplace le service d’abonnement annuel. Vous trouverez la Gazette royale à l’adresse suivante :

http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/
attorney_general/royal_gazette.html

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/
procureur_general/gazette_royale.html

Print-on-demand copies of The Royal Gazette are available, at
the following address, at $4.00 per copy plus 5% tax, plus
shipping and handling where applicable.

Nous offrons, sur demande, des exemplaires de la Gazette
royale, à l’adresse suivante, pour la somme de 4 $ l’exemplaire, plus la taxe de 5 %, ainsi que les frais applicables de
port et de manutention.

Legislative Services
Office of the Attorney General
Chancery Place
675 King Street
P.O. Box 6000
Fredericton, NB E3B 5H1

Services législatifs
Cabinet du procureur général
Place Chancery
675, rue King
C.P. 6000
Fredericton (N.-B.) E3B 5H1

Tel: 506-453-8372
E-mail: gazette@gnb.ca

Tél. : 506-453-8372
Courriel : gazette@gnb.ca

Note: Deliveries are to be addressed to The Royal Gazette and
left with the Commissionaire.

Note : Toute livraison étant adressée à la Gazette royale doit
être remise au commissionnaire.

QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK

© IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK

All rights reserved / Tous droits réservés



Source Exif Data:
File Type                       : PDF
File Type Extension             : pdf
MIME Type                       : application/pdf
PDF Version                     : 1.5
Linearized                      : No
Author                          : giselel
Create Date                     : 2015:01:14 15:32:32-04:00
Modify Date                     : 2015:01:14 15:37:20-04:00
XMP Toolkit                     : Adobe XMP Core 5.2-c001 63.139439, 2010/09/27-13:37:26
Creator Tool                    : PScript5.dll Version 5.2.2
Metadata Date                   : 2015:01:14 15:37:20-04:00
Format                          : application/pdf
Title                           : The Royal Gazette / Gazette royale (15/01/21)
Creator                         : giselel
Producer                        : Acrobat Distiller 10.0.0 (Windows)
Document ID                     : uuid:043ceb59-e89d-4035-92b8-8fd4fe5bc684
Instance ID                     : uuid:71fb859b-7318-454e-8a54-8fc3d2a3b868
Page Count                      : 32
Warning                         : [Minor] Ignored duplicate Info dictionary
EXIF Metadata provided by EXIF.tools

Navigation menu