The Royal Gazette / Royale (15/01/21) 504241 Rg20150121
User Manual: 504241
Open the PDF directly: View PDF .
Page Count: 32
Download | |
Open PDF In Browser | View PDF |
The Royal Gazette Gazette royale Fredericton New Brunswick Fredericton Nouveau-Brunswick ISSN 1714-9428 Vol. 173 Wednesday, January 21, 2015 / Le mercredi 21 janvier 2015 Notice to Readers 61 Avis aux lecteurs The Royal Gazette is officially published on-line. La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne. Except for formatting, documents are published in The Royal Gazette as submitted. Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dans la Gazette royale tels que soumis. Material submitted for publication must be received by the Royal Gazette Coordinator no later than noon, at least seven working days prior to Wednesday’s publication. However, when there is a public holiday, please contact the Royal Gazette Coordinator at 453-8372. Les documents à publier doivent parvenir à la coordonnatrice de la Gazette royale, à midi, au moins sept jours ouvrables avant le mercredi de publication. En cas de jour férié, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de la Gazette royale au 453-8372. Elections New Brunswick Élections Nouveau-Brunswick 30 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF SAINT JOHN EAST (District No. 30) / ASSOCIATION DU PARTI LIBÉRAL DE SAINT JOHN-EST (Circonscription no 30) Official Agent / Agent officiel Tom Davidson 9, rue Alpine Street Saint John, NB E2J 2X3 The Royal Gazette — January 21, 2015 62 Business Corporations Act Gazette royale — 21 janvier 2015 Loi sur les corporations commerciales Notice of a decision to dissolve provincial corporations and to cancel the registration of extra-provincial corporations Avis d’une décision de dissoudre les corporations provinciales et d’annuler l’enregistrement des corporations extraprovinciales Notice of decision to dissolve provincial corporations Take notice that the Director under the Business Corporations Act has made a decision to dissolve the following corporations pursuant to paragraph 139(1)(c) of the Act, as the said corporations have been in default in sending to the Director fees, notices, and/or documents required by the Act. Please note that 60 days after the date of publication of this Notice in The Royal Gazette, the Director may dissolve the corporations. Avis d’une décision de dissoudre les corporations provinciales Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations suivantes en vertu de l’alinéa 139(1)c) de la Loi, puisque lesdites corporations ont fait défaut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/ ou documents requis par la Loi. Soyez avisé que 60 jours après la date de la publication du présent avis dans la Gazette royale, le Directeur pourra dissoudre lesdites corporations. 001900 051342 051521 051526 051532 056499 058783 059301 059435 636431 504197 506451 511146 511244 511318 511319 515980 516071 516195 605106 605251 605424 605444 611144 616950 617127 617156 617255 617330 617335 623573 623644 623672 623694 623707 624052 624063 630036 630068 630336 636476 636498 636682 636791 636798 636823 643047 643175 649120 649469 649493 655621 655680 655684 655752 001900 N.B. Inc. 051342 N.B. LTD. 051521 N.B. LTD. 051526 N.B. LTD. 051532 N.B. LTD. 056499 N.B. LTD. 058783 N.B. LTD. 059301 N.B. LTD. 059435 N.B. LTD. 3409 RUE PRINCIPALE INC. 504197 N.B. LTD. 506451 N.B. LTD. 511146 N.B. Ltd. 511244 N.B. Inc. 511318 N.B. LTD. 511319 N.B. Ltd. 515980 N.B. Ltd. 516071 N.B. Ltd 516195 N.B. Ltd. 605106 N.B. INC. 605251 N.B. LTD. 605424 N.-B. Ltée 605444 N.B. INC. 611144 NOUVEAU-BRUNSWICK CORPORATION 611144 NEW BRUNSWICK CORPORATION 616950 N.B. Ltd. 617127 N.B. LTD. 617156 NB Ltée 617156 NB Ltd. 617255 N.B. Ltd. 617330 NB Ltd. 617335 N.B. Inc. 623573 New Brunswick Ltd. 623644 NB Inc. 623672 NB Ltd. 623694 NB LTEE 623707 NB Ltd. 624052 N.B. Inc. 624063 N.B. Inc. 630036 N.B. Ltd. 630068 NB LTD. 630336 N.B. INC. 636476 N.B. Ltd. / 636476 NB Ltee 636498 NB LTD. 636682 NB INC. 636791 N.B. Ltd. 636798 N.B. Ltd. 636823 N.-B. INC. 643047 N.B. Inc. 643175 N.-B. Inc. 649120 NB INC. 649469 NB Inc. 649493 N.B. Ltd. 655621 N.B. LTD. 655680 N.B. Ltd. 655684 NB LTD. 655752 N.B. Ltd. 655838 655868 655901 655904 661958 661974 662015 662041 662080 662081 662082 662179 662205 662267 662285 662287 662364 662375 662391 662400 662413 668242 668291 668334 668607 668744 668756 668831 668856 668916 051529 662083 642738 008760 610884 668261 655763 668720 624028 501582 649137 662264 000647 643184 611036 605478 605236 662118 649092 617126 605384 662050 655838 NB Inc. 655868 N.B. LTD. 655901 NB INC. 655904 NB Inc. 661958 N.B. Ltd. 661974 N.B. Inc. 662015 N.B. Ltd. 662041 NB Inc. 662080 N.B. LTD. 662081 N.B. INC. 662082 Nouveau-Brunswick Inc. 662179 NB Inc. 662205 N.B. Inc. 662267 N.-B. INC. 662285 NB INC. 662287 N.B. INC. 662364 N.B. Ltd. 662375 N.B. Inc. 662391 N.B. Ltd. 662400 NB Inc. 662413 N.B. Inc. 668242 NB LTD. 668291 NB Inc. 668334 N.B. Inc. 668607 N.B. Ltd. 668744 N.-B. Ltée 668756 N.B. Inc. 668831 NB INC. 668856 NB LTD. 668916 NB Ltd. A & J CONSTRUCTION LTD. A & M Rentals Ltd. A. BERTIN & FILS LTÉE - A BERTIN & SON LTD. A. G. JEAN LTEE. ABC Adventures Ltd. Adica Group Inc. AEG Innovation & Design Inc. AIRLOK INSULATION LTD. AJM HOLDINGS INC. ALDOUANE AQUACULTURE LTEE. Alma Park Store Ltd. ALTROLS CONTRACTING INC. APPLEWOOD ACRES LTD. Arctic Light Construction Ltd. ARSENICK CORPORATION ATCON PROPERTY HOLDINGS INC. ATCON STRUCTURES INC. Atlantic College of Information Technology / Collège des Technologies de l’Information de l’Atlantique Inc. Avonmark Capital Limited Balticum Business Group Ltd. BARTHOLOMEW RIVER DEVELOPMENT LTD. BASALTIC SOLUTIONS INC. 053516 BEJEWEL BY TRUDY GALLAGHER LTD. 617089 BELLEISLE GARDENS GREENHOUSE NURSERY INC. 636412 BERNCOR HOLDINGS LTD. 514012 BH STATION SERVICE LTEE 668843 Blue Sky Properties Ltd. 668646 Bob & Ron’s Transportation Ltd. 043954 BOBA HOLDINGS INC. 636896 Boom Crane Rental Services Limited 623604 Boucher Sales Ltd. 642781 Boum Distribution and Marketing Inc. 623632 Brantville Acquaculture Ltee. 033260 BRASETTE LA CHALOUPE LTEE 059454 BREAK 4 LOGGING LTD. 649312 Brew-Tec Concrete Ltd. 649232 Bruce Brown Construction and Renovation Ltd. 605454 BRUNSWICK PLUMBING SERVICES LTD. 656032 Burgess Freight Carriers Inc. 002678 C & K ENTERPRISES LTD. 002747 CABOT LUMBER LTD. 611158 Caledonia Collision Center Inc. 056716 CAMCO CONSTRUCTION LTD. 642667 Capital Airways Inc. 003127 CAROL HOLDINGS LTD. 668617 CAS Roofing & Siding Ltd. 046241 CASEY SPRING LUMBER LTD. 048737 CHALEUR AUTO SERVICE LTD./ LTEE 610802 Chester Holdings Ltd. 508759 Classic Comfort Company Ltd. 053609 COCAGNE EXCAVATING LTD. 668822 Cold Fall Corporation 516190 CONCEPT PED HOLDING INC. 636430 Corporation professionnelle Dre AdamaRabi Youla MD Inc. 046708 CROWN FENCE SUPPLY LTD. 668299 Cut-er-All Concrete Sawing and Drilling Ltd. 616946 D & R Custom Cedar Inc. 031618 D. & M. CRANE RENTAL LTD. 041291 D.E.M. HOLDINGS INC. 662401 DAKIN’S CONTRACTING LTD. 056671 DALEY FAMILY HOLDINGS LTD. 501852 DALY INVESTMENTS LTD. 636429 DAN DOUCET CONSULTANT INC. 662232 Daniel Castonguay Holdings Inc. 668091 Davenport Trucking Inc. 630470 DAVID & ABRAHAM INC. 668627 David H. Dunsmuir (2013) Professional Corporation 636635 Deke’s Enterprises Ltd. 004891 DELUXE FISH & CHIPS LTD. DELUXE FISH & CHIPS LTEE 648693 Dépanneur Guitard Inc. The Royal Gazette — January 21, 2015 513964 Dépanneur Léger Inc. 038934 DES’S FURNITURE REFINISHING (1987) LTD. 636750 DESIGN 4 SPACE INC. 623831 Double Diamond Management Ltd. 044015 DOUG CHASE ENTERPRISES LTD. 668919 DOWNFORCE AUTOWORKS INC. 617360 Dr Frédéric Goguen c.p. Inc. 605210 DR. DENISE DUGUAY-VIBERT CORPORATION PROFESSIONNELLE INC. 655683 Dr. Matthieu Gaudet Corporation Professionnelle Inc. 668608 Dr. Oludara-Fadare P.C. Inc. 508849 Dr. Peter Feero P.C. Inc. 649198 Dr. S.M.P. Tran Professional Corporation 051469 DR. T. TOUDJIAN PROFESSIONAL CORPORATION 516205 Dre MÉLANIE CHAREST C.P. INC. 668243 Dre Micheline Boucher-Robichaud C.P. Inc. 514025 Dream Kitchen Plus Ltd. 649581 DROST CONSTRUCTION INC. 041305 E. F. CHRISTIE & SONS INC. 516300 Eastern Canadian Maple Products Inc./ Produits d’Erable de l’Est canadien Inc. 605455 EastServe GroundsCare Inc. 655731 EDWARD DOIRON CONSULTING LTD. 041389 EFFECTIVE PARTICLE TECHNOLOGIES LTD. 649434 Egg Films NB Inc. 617376 ELEMENTAL CODEWORKS INC. 668681 ELLE EST BELLE SERVICES CORP. 636745 Embracor Ltd. 623553 EMC Executive Management Consulting Inc. 656091 ENCORE ATM-POS INC./ENCORE GAB-TPV INC. 655632 Enigma Movie and Scripts Corporation 668695 ENTER RENOVATIONS INC. 630447 ENTREPRISES J.V.L. INC. 030082 ENTREPRISES MALLET LIMITEE 630438 ESQU CERTIFIED LTD. 636759 F & G EURO FLOORING LTD. 662280 Faithful Servant Books Inc. 059494 FERME ARMAND GODBOUT LTEE 656092 Ferme J & D.L. Farms Inc. 605394 FISH-ON-BAIT COMPANY, CANADA LTD. 649259 FourJ Steel Incorporated 662099 Franzen Canada Corp. 649531 FRESH FROM THE SEA LTD. 504231 FROSTY HOLLOW SYLVACULTURE & LOGGING INC. 668913 FUNDY LASERFAB LTD. 511192 G.A. DUNCAN ELECTRIC LTD. 655770 GERT’S PLACE INC. 053525 GESTION B & M MICHAUD LTEE 007089 GESTION MOCO LIMITEE 501725 GESTION R. CYR MANAGEMENT INC. 504171 GLENCO HYDROSPRAYER LTD. 053610 GLOBAL MECHANICAL SYSTEMS LTD. 501732 GOLD COAST MARINE CONSULTANT INC. 059440 GOLDEN SISTERS LIMITED 053399 GOULD’S FRIED CLAMS LTD. 007503 GREEN’S RESTAURANT LIMITED 662274 GROUNDS EFFECTS LANDSCAPING LTD. 034987 HAINES PHARMACY LTD. 668315 HDR Motorsports Ltd. 649464 Headway Rehabilitation Inc. 668325 hearingaidrental.ca Ltd. 642758 Hickory Holdings Ltd. 031531 HOLLAND FOOD IMPORTS LTD. 504241 HYDRA-FAB INDUSTRIAL INC. 63 516283 655940 668781 668348 041207 034901 623990 636817 052315 668939 617188 668895 610893 649479 504084 059532 056585 662380 616869 656066 513951 668592 504116 008462 049264 616998 662173 668905 649562 668276 655790 649440 668342 649563 031534 642879 642953 649388 056335 516166 642791 668302 516251 649345 668824 516275 030124 010241 501710 617025 511266 649280 051461 516343 605419 010409 516276 010749 010768 011742 010823 010889 056521 513948 038874 605267 655708 662342 Ian J. Warren Ltd. IFJ West Holdings Ltd. IMEX Sourcing Inc. Immilease Inc. IMPRESSION PROMOTION LTD. INDIAN ISLAND VACATIONS INC. INDUSTRIAL HYDRO-VAC NB LTD. INSTITUT BEAUBASSIN INC. INSTITUT EDUKA INC. Intergrated Systems Consulting Inc. INVESTISSEMENTS DDH INC. Iron Wolf Mining Inc. J & J Cummings Housing Ltd. J. Cloutier Professional Corporation J.K.S.V. ENTERPRISES LTD. J.S. SHIPBUILDING CONSULTANTS LTD. JAMES F. IZZARD PROFESSIONAL CORPORATION Jamie Cummings Housing & Development Ltd. JEMDAC INC. Jenta Engineered Solutions Ltd. JIM’S FAMILY CONVENIENCE STORE LTD. Joel’s Pizza Inc. JOGE ENTREPRISE LTD JOHN L. INGERSOLL & SONS LTD. JOHN MCGUIRE SALES LTD. John Mick Inc. JVY TRANSPORT INC. K & L Electric Ltd. KA&LMD Holdings Inc. Kentin Forestry Inc. KHD - KustomHAUS Designs Inc. Knight North America Corp. KST Tech Group Inc. L&KAMD Investments Inc. LAITERIE MARTEL LTEE Landi Investments Inc. Le coin des pecheurs 2009 Inc. Le Restaurant Familial Jac-Pit Inc. LES ENTREPRISES HARRY FRYE LTEE Les entreprises Lanwon Inc./Lanwon Enterprises Inc. LET’S PLAY ENTERTAINMENT LTD. LinkState Technologies, Inc. Little Sneakers Daycare Inc. LOAAT CONSULTING (N.B.) INC. LONE TREE VENTURES INC. LONGING VENTURES INC. M. J. SCHMIDT & SON LTD. M. T. A. SALES LTD. M.C. TRIMMING & CUTTING TREE LTD M.D. PELLERIN LUMBER INC. M.P. AQUACULTURE INC. M.R. Service Center Ltd. MACDOUGALL’S FARM LTD. MacKELLAR CUNNINGHAM & ASSOCIATES LTD. MacPherson Group Limited MAPLE GROVE TRAILER PARK LTD. Marco & Clarence Forestiere Ltee MATTHEWS BROS. LTD. MAYFAIR BEVERAGE ROOM (1979) LTD. MCKINNEY MANAGEMENT SERVICES LTD. MEL ENTERPRISES LTD. MERV’S CATERING RESTAURANT & BAKERY LTD. Metlantech Inc. MILLIGAN’S CYCLE WORKS INC. MINTO FINE FURNITURE LTD Miramichi Career College Inc. mode de vie Carelle’s lifestyle Inc. MONEY CAFE INC. Gazette royale — 21 janvier 2015 011397 649333 610888 668633 668341 655915 668872 668647 506522 649208 656036 668864 655704 511373 511092 636920 662167 013132 049213 041390 516238 649154 504083 649256 605323 623574 031434 668701 516191 649067 649354 506432 056436 056575 655642 610911 623625 034899 513913 642905 624015 014502 643022 623648 044000 643001 014961 617366 662146 668860 053464 649285 041224 668845 668593 655742 654456 015451 668873 630251 043944 636897 668591 668308 630163 668680 MORUE IMPERIALE LTEE MSL Carriers Ltd. MULTI-RECYCLING LTD. N.J.E. Enterprises Inc. North East Paper Inc. NRG Durable Inc./Durable NRG Inc. O.I. Holdings Inc. onVDO Corporation P & A TIMBER INC. Palmer Management Services Ltd. Panacea Body Wellness Centres (NB) Limited PARA BEAUTY INC. Patient Television Services Inc. PATRICK L. MURCHISON PROFESSIONAL CORPORATION PCS LabMentors LTD. PERPETUAL SECURITY CORPORATION Pièces Parts Expert Inc. PINES ENTERPRISES LTD. PORCHERIE DU CENTRE V.T. INC POWER PLAY SPORTS & HOCKEY CLINICS INC. PRATIQUE MEDICALE CORMIER & OUELLETTE C.P. INC. Premium ESL Canada Inc. PRINCE EDWARD DEVELOPMENTS LIMITED Profloor Installs Ltd. PRS Enterprises Ltd. R & S Mining Consultants Inc. R. LANDRY HOLDING LTD. R.W. Morton Construction Inc. RESIDENCE COMPLEXE BONACCORD INC. RESTIGOUCHE AQUACULTURE LTD. Restigouche Centre of Excellence in Athletic Skill Development Inc. REYNOLDS RV SALES LTD. RICHARD SHEET METAL LTD. RITCHIE’S PLUMBING & HEATING INC. River Bend Consulting Inc. RIVERSIDE COACH LINES INC. Riverview Comfort Inc. RIVERVIEW MUFFLER CENTER LTD. RMLE Location Ltée ROWCOR Technologies Inc S.A. ORR & SEARS LTD. SABRA LIMITED San Wen Feng Shui Planning Corporation Inc. Savage’s Bicycle Centre Inc. SCOTT IRVING SHEET METAL LTD. SEA DREAM FISHERIES LTD. SECURITY PHOTO PROFILE LTD. SERGE H. BRIDEAU GARAGE & SCRAP METALS LTD Serre APOLO Greenhouse Inc. SGN Construction Management Inc. SHAMROCK HOLDINGS LTD. Silver Daisy Designs Inc. SILVER HARVEST LTD. Smile a While Dairy Bar Inc. Snack & Bevy Shack Inc. Solstice Soap Co. Inc. Spa Chance Harbour inc. SPENCER TRUCKING LIMITED Stephen LeBlanc Financial & Investment Services Ltd. Stewart & Stevenson Canada Inc. STIEF LTD. Sugar Island Foods Inc. SUITE SERENDIPITY LTD. Sunray Solar Inc. Sunrise Diner Ltd. Supreme Energy Centre Inc. The Royal Gazette — January 21, 2015 660458 649118 617294 655913 668323 053283 668238 049197 508779 Synergy Properties Inc. T & G Holdings Incorporated T.J. MAILLET RESIDENCES LTD. Taylor Lake Aggregates Inc. TECHVEDIC NEW BRUNSWICK INC. TEDISH HOLDING LTD. Telefoniks Digital Inc. TexMedico Inc. The Washburn Group Financial Advisors Inc. 056515 TILLEY TAKE-OUT LTD. 662332 TJM ENTERPRISES INC. 64 623977 610775 617300 016369 636793 668786 016657 649568 643170 649127 Gazette royale — 21 janvier 2015 Tom Egers Excavating Ltd. Transport 04 Inc. Travacom Properties Inc. TRI-GIL PAVING & CONSTRUCTION LTD Tritium Software Inc. TruGreen Landscaping Ltd. VALLEY DISTRIBUTORS LTD. Verge Point Construction Ltd. VICTORIA GROWERS LTD. Vista Ridge Homes Inc. 051421 VOLUME TRUCK & EQUIPMENT SALES LTD. 016898 WALKER & ASSOCIATES LTD. 636828 Waveney Holdings Inc. 617187 WEST-WOOD MANUFACTURING LTD. 662147 Wet to Dry Basement Solutions Inc. 030116 WINDOWS INTERNATIONAL SALES & INSTALLATION LTD. 610966 XTRA PC INC. 617303 ZEAN’S AUTO REPAIR LTD. 668841 Zliv Creations Inc. ____________________ ____________________ Notice of decision to cancel the registration of extra-provincial corporations Take notice that the Director under the Business Corporations Act has made a decision to cancel the registration of the following extraprovincial corporations pursuant to paragraph 201(1)(a) of the Act, as the said corporations have been in default in sending to the Director fees, notices, and/or documents required by the Act. Please note that 60 days after the publication of this Notice in The Royal Gazette, the Director may cancel the registration. Avis d’une décision d’annuler l’enregistrement des corporations extraprovinciales Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision d’annuler l’enregistrement des corporations extraprovinciales suivantes en vertu de l’alinéa 201(1)a) de la Loi, puisque lesdites corporations ont fait défaut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou documents requis par la Loi. Soyez avisé que 60 jours après la date de la publication du présent avis dans la Gazette royale, le Directeur pourra annuler l’enregistrement desdites corporations extraprovinciales. 655809 636597 662144 662197 668752 623612 636785 668597 076635 649048 662126 649099 636853 073144 630088 2081109 ONTARIO INC. 3089-2400 Québec Inc. 8078637 Canada Inc. 8100896 Canada Inc. 8407690 Canada Inc. Advantage Communications Inc. AKVA group North America Inc. Alimentation L’épicier inc. ALLIED INTERNATIONAL CREDIT CORP./SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE RECOUVREMENT ALLIED INC. ASSET APPRAISAL SERVICES (CANADA) INC. SERVICE D’ÉVALUATION D’ÉQUIPEMENTS (CANADA) INC. Breakwater Resources Ltd. Centric Disability Management Inc. CLOVERCONCEPT INVESTMENTS LTD. COMSTOCK CANADA LTD. Connor, Clark & Lunn Private Capital Ltd. 624030 668736 649065 662115 630047 649590 073624 630384 668868 661810 623968 630385 654367 668163 655956 078090 643051 DR CHARLES JOURNET P.C. INC. DTComposite Ltée Dynamic Tire Corp. Edulife Centre Eduvie Inc. Entreprises forestières sapins Verte inc Futurebright Insurance Group Inc./Groupe Assurances Futurebright Inc. GOJIT INC. GROUPE MÉGA SERVICE INC. HOLLOWAY LODGING CORPORATION IAM Building Systems Inc. IGRI INC. J. H. SAUVÉ ET FILS (1979) INC. KARRYS BROS., LIMITED Les Gestions Lecram Ltée. Les Systèmes Equinox Inc. MILLER INTERMODAL LOGISTICS SERVICES, INC. NEXIM CANADA INC. 078062 Nortel Networks Technology Corporation/Corporation Technologie Nortel Networks 668255 PIONEER FUELS INC. 661998 Point Zero One Realty Limited 630300 QUADRA CHEMICALS LTD. 624044 QUANTUM MURRAY GP INC. 019661 SEAMARK ASSET MANAGEMENT LTD. 668734 SHS SERVICES MANAGEMENT INC GESTION DES SERVICES SHS INC. 629804 TD SERVICES PLUS INC. 662372 TECHNOLOGIES SYNERSTAR INC. SYNERSTAR TECHNOLOGIES INC. 077560 W.T. RAWLEIGH CO. 662388 WEEKES GENERAL CONTRACTING LTD. 668237 WINMAR FRANCHISE CORP. 649369 WJC MAINTENANCE SERVICES LTD. 643092 WOODY’S AUCTIONS LIMITED Companies Act Loi sur les compagnies Notice of decision to dissolve provincial companies Take notice that the Director under the Companies Act has made a decision to dissolve the following companies pursuant to paragraph 35(1)(c) of the Act, as the said companies have been in default in sending to the Director fees, notices, and/or documents required by the Act. Please note that 60 days after the date of publication of this Notice in The Royal Gazette, the Director may dissolve the companies. Avis d’une décision de dissoudre les compagnies provinciales Soyez avisé que le Directeur, en application de la Loi sur les compagnies, a pris la décision de dissoudre les compagnies suivantes en vertu de l’alinéa 35(1)c) de la Loi, puisque lesdites compagnies ont fait défaut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou documents requis par la Loi. Soyez avisé que 60 jours après la date de la publication du présent avis dans la Gazette royale, le Directeur pourra dissoudre lesdites compagnies. 022293 Association régionale de la communauté francophone de Saint-Jean inc. 003081 CARLETON CURLING CLUB, LIMITED. 024895 CARLETON MANOR FOUNDATION INC. 003307 CENTRE COMMUNAUTAIRE PAROISSE STE-CECILE SPORTS & LOISIRS, INC. 021774 CODIAC VIKINGS AQUATIC CLUB INCORPORATE CLUB AQUATIQUE CODIAC VIKINGS INCORPOREE 025258 COMMISSION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU GRAND SHIPPAGAN INC. 004143 CONGREGATION SHAAREI-ZEDEK, LIMITED 004182 CONSEIL RECREATIF DE STE. MARIE INC. The Royal Gazette — January 21, 2015 65 630071 Curryville Community Outreach Center Inc. 668909 D.D Net Works Inc. 022530 DEJA VU/SECOND HAND CLOTHING STORE INC. 025229 DEVELOPMENTAL SERVICES (SAINT JOHN) INC. 025687 EATING DISORDER COUNCIL OF NEW BRUNSWICK INC. 006298 FLORENCEVILLE CURLING CLUB, LTD. 668270 Friends of Cameroon Inc. 668637 Grappe en Composites NB Inc. - NB Composites Cluster Group Inc. 024137 HILLSBOROUGH KIWANIS COMMUNITY CENTER, INC. 008545 IRISHTOWN COMMUNITY CENTRE INC. 025834 JUDO NB INC. 623725 JUSTICE & EQUITY Inc. Gazette royale — 21 janvier 2015 024560 KENNEBECASIS VALLEY HIGH SCHOOL ACTIVITIES COMMITTEE, INC. 024366 LAKEHEAD R.V. CLUB INC. 023321 LE MOUVEMENT SCOUTS ET GUIDES DE DRUMMOND INC. 024332 LES POMPIERS DE SAINTE-ANNE DE MADAWASKA INC. 662328 Lutte New Brunswick Wrestling Inc. 006783 Manufactured Housing Association of Atlantic Canada Inc. 025840 Marathon by the Sea, Inc. 011544 MCADAM LIONS CLUB INC. 630099 Moncton Flyers Hockey Club Inc. 024361 MOUNTAINVIEW TRAILMAKERS SNOWMOBILE CLUB INC. 024892 NASHWAAK WATERSHED ASSOCIATION INC. 023605 PARTAGE & AMITIE INC. Partnerships and Business Names Registration Act TAKE NOTICE that, pursuant to sections 12.3 and 12.31 of the Partnerships and Business Names Registration Act R.S.N.B., 1973, c. P-5, the Registrar under the said Act intends to cancel the registration of the certificates of partnership of the firms set forth in Schedule “A” annexed hereto and the certificates of business names of the businesses set forth in Schedule “B” annexed hereto by reason of the fact the said firms and businesses have failed to register certificates of renewal in accordance with paragraph 3(1)(b) or (c) or subsection 3.1(2) or 9(7), as the case may be applicable, of the said Act. FURTHER TAKE NOTICE that at any time after the expiration date of thirty (30) days from the date of publication of this Notice, the Registrar may cancel the registration of the said certificates of partnerships and certificates of business names. 605525 PETTY TRAIL BLAZERS ATV CLUB INC. 668820 Renewed Hope Church of God Ltd. 667489 Réseau d’inclusion communautaire de Kent/Kent Community Inclusion Network Inc. 636835 ROCKINGSTONE GARDEN HOMES INC. 023328 SAINT JOHN ASSOCIATION FOR COMMUNITY LIVING, INC. 668721 ST. JAMES COMMUNITY FOUNDATION INC. 021533 ST. MARY’S CEMETERY LTD. CIMETIERE STE MARIE LTEE 022080 STICKNEY & AREA RECREATION COUNCIL INC. 023333 THE JOHN HOWARD SOCIETY OF FREDERICTON, INC. 016190 TIFERES ISRAEL LTD. Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales SACHEZ QUE, conformément aux articles 12.3 et 12.31 de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, L.R.N.-B. de 1973, chap. P-5, le registraire a l’intention, en vertu de ladite loi, d’annuler l’enregistrement des certificats de sociétés en nom collectif indiquées à l’annexe « A » ci-jointe et des certificats d’appellations commerciales des commerces indiqués à l’annexe « B » ci-jointe, en raison du fait que ces firmes ou commerces ont négligé de faire enregistrer des certificats de renouvellement conformément à l’alinéa 3(1)b) ou c) ou au paragraphe 3.1(2) ou 9(7) de ladite loi, selon le cas. SACHEZ AUSSI qu’en tout temps après la date d’expiration de trente (30) jours à partir de la date de publication du présent avis, le registraire peut annuler l’enregistrement desdits certificats de sociétés en nom collectif et certificats d’appellations commerciales. Schedule “A” / Annexe « A » Certificates of Partnerships / Certificats de sociétés en nom collectif 647510 609363 648462 647801 647817 647655 609496 Alward Brothers Farm ANNCATH-ROBY CRAFTS ATLANTIC CONCIERGE SERVICE Canned Games Cargojet Regional Partnership COLOR GLO NEW BRUNSWICK DREAM COTTAGE 646602 647479 648292 348062 647623 609418 647803 Dream Fitness GAGNE ET CYR OPTOMETRISTES Gower Exteriors GRAHAM EXPORT SALES Green Acres Estate Kchikhusis Daycare Le Petite-Chapeau 603570 647332 647525 345806 609550 647622 Les Moulures Lumar Mouldings Maritime Spray Foam SHERMTREV ENTERPRISES Spacek & Norrad Chartered Accountants Thornton Projects V-Sure Enterprises ____________________________________________________ Schedule “B” / Annexe « B » Certificates of Business names / Certificats d’appellations commerciales 647631 646899 615443 615225 647874 21st Century Resumes 878 Waterfront Bistro & Café Acadie Trophy ACE OF TRADES CONTRACTING ADDICTION PSYCHIATRY AND METHADONE CARE (MIRAMICHI) REG’D. 609565 ADORABLE 608777 ADRIEN CHARPENTIER MENUISIER 609404 ADVANCED ADHESIVES 647786 ALBO’S BUILDING AND RENOVATIONS 648182 ALL IN ONE MUSIC 647936 ANGEL CITY TATTOOS 648277 Aqua Blast Hot Tubs Sales & Service 615705 Arthur Ross A M Trucking 342857 Association des Bibliothécaires et Professeur.e.s Retraités de l’Université de Moncton 648468 ASTRO C. D. TRUCKING 647693 At Your Finger Tips-Est.2009 646968 609636 647723 609519 647759 647834 641616 647710 609300 ATLANTIC AIR AMBULANCE Auberge Centre-Ville Enr. AUBERGE PITOU EN VACANCE AUDUBON ORGANICS B&J CARPENTRY & GARDENING B.W. Auto Cleaning Specialists Balanced Viewpoint Barry’s Discs BASKET SHOPPE QUALITY GOURMET GIFTS 647658 Bay of Fundy Shark Fishing Charters The Royal Gazette — January 21, 2015 648174 609380 648330 647615 648117 647947 647941 647534 647897 647752 648298 647636 647503 647574 647924 647257 647271 647272 647270 648472 647721 647626 615488 310810 332553 647856 647733 615634 647504 647546 647547 647585 647582 647624 648401 615650 646727 647549 615391 648098 615403 615455 616358 647666 337759 648483 647505 609554 335044 615727 610164 615665 647506 647516 647572 615608 647701 322081 647772 609391 647511 647099 647888 647512 340679 Berry’s Auto & Recreation Bertelsen Properties BEST ALARMS Beyond Bronz Tanning BGP Technologies Bolduc Forestry Services Boost Research & Development Bordertown Collision Centre Boudreaus Bay AutoBody BOUTIQUE 31 Brian McCulloch’s Small Engine Repair Britta’s Bear Island Bed & Breakfast Bronzage D’Azur Buen Dia Canada C.B. DeMerchant & Sons CANACCORD ADAMS CANACCORD CAPITAL CANACCORD INSURANCE SERVICES CANACCORD WEALTH MANAGEMENT CANACCORD WEALTH MANAGEMENT CANARGY FOODS Canuck Web Services Capital Spring and Suspension CARLETON-KIRK LODGE CARTIER WINES & BEVERAGES CBW Bookkeeping Services CENTRE AUDITIF BEAUSÉJOUR HEARING CENTER Centre Dentaire Elmwood/Elmwood Dental Centre Charlotte County P.M.S. Property Management Services CITICORP HOME MORTGAGE CITICORP HYPOTHÈQUES RÉSIDENTIELLES CLEAN VOLT ATLANTIC Clinique l’Endodontie de Grand-Sault/ Grand Falls Endodontics Clinic Clinique Myocare Clinic Cobalt Crow Productions Cogerno Coiffure PraDá Coldwell Banker Dynamic Realty COLWELL SECURITY SYSTEMS Cool Cat Creations Corkum Photographics Country Studio Countrycatz Coverdale Renovations COX COMMUNICATIONS CRC CONSULTANTS & RÉPARATIONS CLINIQUE / CRC CLINICAL REPAIRS & CONSULTANTS Creative Boss CREDIT CONSEIL PLUS DU N B CREDIT CONSULTANTS PLUS OF N B CURL’N COMB D-micro Technology D. ELLIS AUTO SALES Danielle’s Lingerie DAVE’S REFINISHING SERVICES DAY & ROSS TRADE NETWORKS Depanneur & Station Service Harricana Dependable Auto Sales Dixon Plumbing & Heating DOBSON CHRYSLER DODGE DOCTEUR GUM DOCTOR DOOLY’S BLUE ROOM DOWN EAST MOBILE WASH Down the Lane Beauty Salon Dr. Dish, Satellite TV Specialist DT PIZZA DUPMAG CONSULTATION 66 647653 EAST COAST PEOPLE’S CHOICE AWARDS 648427 Eastern Paint Ball Supplies 647792 Easy Travel 647876 ECO - ART UNLIMITED 647804 Eco Clean 648314 Elm Creek Livestock Equipment 647917 Empire Stevedoring (Maritimes) Co. 647760 Enseignes Maximum Signs 615384 EXPLORE YOUR WORLD DAYCARE 647955 EXTREME DRIVEWAY SEALER 647565 Eye Shine Studio 615801 FCPC 648143 Fire & Ice Graphix 615591 First Organic Bakery 646494 Fitness Excellence Athletic Training (FEAT) 647603 Flight Graphics and Design 615800 FOOD AND CONSUMER PRODUCTS OF CANADA 647903 FOREVER YOUNG SPECIAL CARE 615592 Fournier & Associés Enr. 647575 Fredericton Mitsubishi 314185 FREDERICTON REALTY 648220 FRESH GROUND CAFE 647643 FRONTIER DIVING 647621 Fruit Sendsations 647755 Fundy Medical Supplies 647497 Future Dream Ventures 647814 GAIA DESIGNS 647629 GALLERY CONNEXION Organization of the Development of Artists 647686 Garage Jacques Michaud 647802 Garderie La cour des grands 647642 GEMM Home Builders & Design 648358 Gentle Touch Footcare 615832 girvanmedia 615696 GLASSWERX NEON SIGNS 615576 Gordon Cowan Plumbing 609385 Grace Adventures 647782 Gray Wolf Photos 648166 GROVE HILL CONSULTING 647771 GUMWIZARD 647911 HARMONY HOUSE VENTURES 648217 Hartt Island RV Resort 609527 Heavenly Gowns Bridal Boutique & Formal Wear 648168 Hennigar & Associates Consulting 615596 HI VENTURE FARMS 647614 HIGH FIVE Early Learning Centre 647514 Howe Technological Services 647532 IATC Marketing and Consulting 609719 ING Novex 648432 Integrity Investigations and Document Service 647866 Intuitive Energy 647928 iSpark Creative Adventures 615840 J. F. Balcomb & Associates 647766 JETPAC Marketing Solutions 609616 JG Comeau & Associates 648207 Jill Little Design 615746 JKM Special Care Home 647315 Jmailer 647673 Joan & J Pet Styling 647651 JOLI Laser Aesthetics 345713 Juniper Construction 647871 K & D Property Maintenance 647865 KamDEN Graphics & Promotions 648093 KAMM-LAB 648094 KAMM-LAB MEDICAL LABORATORY SERVICES 648150 Kelly’s Repair & Service Centre 648489 KEVIN’S GARAGE & TOWING 648491 KEVIN’S TRUCKING 609279 KFC 615631 Kim’s Hair Design 648141 Kimble Convenience 609447 KING STREET SPORTS Gazette royale — 21 janvier 2015 647845 Kings Chapel Funeral Home & Cremation Centre 648418 Kings Way LifeCare Alliance 647849 Kingsclear Construction 648297 Knots Be Gone Massage 648124 Know Fire Canada 337639 L’ACADIE NOUVELLE 647810 L’AUDACIEUSE CUISINE 648086 L5 Media 647698 La Mijoterie 647499 LA SPOT DES PÊCHEURS 647689 Le Centre de Soins au Palace 647634 Le Réseau des Échos du NouveauBrunswick 345823 LeeCom Enterprises 615793 Les Chalets-sur-Mer enrg. 647523 LIL’ NASHIRA MASSAGE 647915 Lise Gallant Bookkeeping Services 647763 Location Daniel Lepage Rental 615842 LONGHORN TRANSPORTATION 648184 Lydon Consulting 648433 Lynn’s Eyebrow Clinic 615770 M & B BLUEBERRY FARMS 647654 M D S WHOLESALERS 648296 M.R.M. Custom Woodwork 647397 MACONNERIE BEL ROC ENR 348233 MADILL’S REFRIGERATION & AIR CONDITIONING 648177 Man Around the House Home Renovations 648275 MAPPINS JEWELLERS 648187 Marc Gould Trucking 645792 mariages créAtioNIK weddings 648265 Maritime Mobile Dj Services 647372 Mary Lou’s Blood Collection Service 647854 MATTCAN TRANSPORT 647858 Max Income Tax 343176 MCVAN ENTERPRISES 648165 Merynic Consulting 647568 Michael Code Insurance 647558 Mighty Duct Cleaners 610169 Mill Cove Convenience 615618 Milled Rite Lumber 647798 MITCHELL HAYNES CONTRACTING 647741 MMMarvellous MMMuffins 647740 MMMuffins 648130 MONCTON PARK N SELL 647536 Mondrian 647537 Mondrian-Hall 647747 Monsieur Bibitte 647526 MORTON PUB 647907 MOUNT PLEASANT VILLAGE 648179 Mr. Movie 648096 MSR Marketing & Sales Agency 615643 Mukonda Canada Venture Partners 647594 My Work Site 331667 NBTel Mobile Office 331549 NBTel Mobility 331668 NBTel Optimizer 648142 Net Tech Solutions 648395 No Bells No Wall Learning - Apprendre sans cloche sans mur 647674 Noella Fleuriste 648415 North End Auto Repair 615511 North Side Collision Miramichi 345745 NUSSEY CONSULTING 647608 OLD TIME CATERING 648149 One-Stop Electronics 648128 OX-BOW FARM 334903 P.W.F. TRANSPORTATION SERVICES 315925 PALADIN FINANCIAL SERVICES 648172 PC Home Canada 647581 PC Techworld 647580 PCTW Networking Group 647652 PEEL PUB 648270 PEOPLES JEWELLERS 335047 PETER DEMERCHANT GENERAL CONSTRUCTION 641608 PHINNEY SALVAGE The Royal Gazette — January 21, 2015 648329 609188 609277 647571 647628 647648 647600 648325 647680 615430 615732 647730 335072 609317 648266 615849 647314 647609 647944 648463 648206 648474 310815 332667 646254 615848 647553 609637 647939 609303 609267 647850 615223 648308 Phototropical by Valerie Biebuyck Pine Glen Designs Pizza Hut PLATINUM PARKING MANAGEMENT SYSTEMS PMW Precision Machine Works Prince Edward Guardian PRINCESS BRIDE WEDDINGS Pro Dent PROMOTIONS BLANCHARD/ BLANCHARD PROMOTIONS PS Consulting QUINCY’S ELECTRIC R & B Under The Red Roof R M B TECH RACHELLE’S CUTS & CREATIONS RBG Consulting Re/Max Hartford Realty Red Door Smokin’ Supplies REEDS POINT PUB & GRILL Renar Animation Repair Pro Auto Résidence chêne de Mambré RetroReplay RITEWAY AUTO LEASING ROBBIE O’NEILL ENTERPRISES Robert Breau Ferme Robin’s Inn Roger’s No Frills Rogersville Auto Salvage S.T.A.R. SOUND THE ALARM RECORDING STUDIO Saint John College SAINT JOHN LASER CLINIC Salon Coiffure Centre-Ville Salon Mexicut Sammy’s Forest Management 67 Gazette royale — 21 janvier 2015 648420 SAPUTO DIVISION PRODUITS LAITIERS (CANADA) / SAPUTO DAIRY PRODUCTS DIVISION (CANADA) 647682 Savi Jewelry 609612 Scierie BLT 647905 Sécurité Financière André Gallant Financial Security 609417 Seeking Balance 646819 SELECT BEAUTY SUPPLIES 647808 Shediac Glass & Maintenance 610166 Shiretown Image Maker 647791 Sinderella’s Toy Box 647583 Sistema Canada 647584 Sistema New Brunswick 648089 Solar Smart Solutions 647855 South East Energy 348168 SPOTLESS JANITORIAL 609290 STUDENT TAXI 647586 SUE’S COUNTRY NOOK 646936 Swath Custom Cutlery Forge and Rehoning 647891 SYNERGYSCREENS 609278 Taco Bell 648334 Tall Oaks Administrative Services 332604 THE AUCTION CENTER 648105 The Big Clean 648216 The Bucket Club Outdoor Activity Park 609333 The Buckley’s Company / la compagnie Buckley 615509 the Computer Aided Bookkeeping company 316198 THE GOODIE SHOP 647559 The Great Canadian Pub Lounge 300380 THE HILLTOP PUB 615822 THE SIDE BAR 648147 The Tin Can Convenience Store 648402 609349 648237 348114 647493 348135 647577 647646 647940 648309 608420 648208 648323 647599 609342 608735 615733 646985 648083 609448 647704 647968 647974 648261 615662 609435 609222 647859 647480 647495 647857 647690 609524 The Vintage Rose Three Apples Arts and Crafts TINA’S ISLAND MARKET TOP DECK RESTAURANT Top Flight Mortgage Centre TOP OF THE TOWN Torsten Linke Trucking Total S.P.O.R.T. Centres Totten Trucking TRIMACK PROPERTY CARE TRIUS TAXI Twilight Night Club Tycho Computers TYTECH SOLUTIONS V-GOLF VCS COST MANAGEMENT SOLUTIONS VF CANADA VIENNEAU QUALITY MERCHANDISE Vinny’s Chip Truck Violette Dental Health Vision Plus VisionA Consultants Viva Mode Wall Property Services WASHADEMOAK COMMUNITY CALENDAR Water Metrics WEIR’S MACHINE SHOP Windy Hollow Enterprises WINTERWOOD NATURAL FOODS WitsEye Publishing WOODSIDE STABLE Woodstock Main Street Convenience WORKIN FOLK ART Business Corporations Act Loi sur les corporations commerciales PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of incorporation has been issued to: SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de constitution en corporation a été émis à : Registered Office Bureau enregistré Reference Number Numéro de référence Date Year Month Day année mois jour DRE JOËLLE DROLET-FERGUSON C.P. INC. Tracadie-Sheila 679937 2015 01 01 Elite 1 MMA Productions Inc. Lakeville 679960 2014 12 15 Boutique Bébé tout neuf inc. Haut-Lamèque 679983 2015 01 01 C. S. Technologies Group Inc. Saint John 680038 2014 12 17 Reference marketing URLs Inc. Saint John 680040 2014 12 17 GESTION PAUL LECLERC INC. Grand-Sault / Grand Falls 680077 2015 01 01 Newmarket Forest Ventures Ltd. Brockway 680079 2015 01 01 Dr. Louis Juravsky Professional Corporation Moncton 680085 2015 01 01 680087 N.B. Inc. Lutes Mountain 680087 2014 12 19 Pro Fuel Plus Ltd. Caraquet 680093 2014 12 19 680094 NB INC. Miramichi 680094 2014 12 19 Name / Raison sociale The Royal Gazette — January 21, 2015 68 Gazette royale — 21 janvier 2015 THERRIEN FABRICATION INC. Edmundston 680095 2014 12 19 680096 NB INC. Miramichi 680096 2014 12 19 TLG Bookkeeping Services Inc. Bathurst 680097 2014 12 19 K & R ELECTRICAL SERVICES INC. Grande-Anse 680101 2014 12 22 Savarin Holdings Limited Saint John 680102 2014 12 22 A.R. Léger Holdings Inc. Moncton 680108 2014 12 22 680115 NB Inc. Lepreau 680115 2014 12 22 680116 NB INC. Saint-Léonard 680116 2014 12 22 Hutt Chiropractic Professional Corporation Miramichi 680117 2014 12 22 Jackie A. Dableh-Hakimian CPA Professional Corporation Fredericton 680119 2015 01 01 680122 N.B. LTD. Douglas 680122 2014 12 22 M.J. Connors P.C. Incorporated Fredericton 680125 2014 12 29 M.J. Connors Services P.C. Incorporated Fredericton 680126 2014 12 29 680127 NB Ltd. Dieppe 680127 2014 12 22 680128 NB Ltd. Riverview 680128 2014 12 22 680129 N.B. Ltd. Fredericton 680129 2014 12 22 AVG Consulting & Bookkeeping Ltd. Moncton 680132 2014 12 22 MAPLE A.L. INC. Saint-Quentin 680134 2014 12 22 Ego Modern Beauty Ltd. Fredericton 680137 2014 12 22 A.W.O.L. BREWERY CORP. Riverview 680138 2014 12 22 Liv9 Nutrition Inc. Nackawic 680141 2014 12 22 680142 N.B. Inc. Saint John 680142 2014 12 22 680144 NB INC. Fredericton 680144 2014 12 23 680147 N.B. INC. Miramichi 680147 2014 12 23 680148 N.B. Inc. Moncton 680148 2014 12 23 Tough Guy Brewing Inc. Fredericton 680149 2014 12 23 680150 NB INC. Fredericton 680150 2014 12 23 680152 NB INC. Sackville 680152 2014 12 23 680153 NB INC. Sackville 680153 2014 12 23 680154 N.B. Ltd. Sussex 680154 2014 12 23 GAR Holdings Inc. Sackville 680160 2014 12 23 680161 N.B. Inc. Fredericton 680161 2014 12 23 M. Chiasson P.C. Incorporated Moncton 680162 2014 12 29 KPC Holdings Inc. Sackville 680163 2014 12 23 M. Chiasson Services P.C. Incorporated Moncton 680164 2014 12 29 BANKERS CAPITAL CANADA LTD. Moncton 680165 2014 12 23 680166 NB Ltd. Moncton 680166 2014 12 23 The Royal Gazette — January 21, 2015 69 Gazette royale — 21 janvier 2015 Dr. Vineeta Sethi P.C. Inc. Fredericton 680167 2014 12 23 R.M. Boudreau P.C. Incorporated Moncton 680174 2014 12 29 R.M. Boudreau Services P.C. Incorporated Moncton 680176 2014 12 29 680177 NB Inc. Monteagle 680177 2014 12 23 Jill Stairs Professional Corporation Fredericton 680179 2014 12 23 Down East Window & Door Ltd. Sussex 680180 2014 12 23 Bronzage Zana inc. Kedgwick 680181 2014 12 23 680182 NB INC. Campbellton 680182 2015 01 01 Corey’s Towing Ltd. Petitcodiac 680183 2014 12 24 RONALD J. SAVOY PROFESSIONAL CORPORATION Moncton 680184 2014 12 31 EMMY CHIASSON PROFESSIONAL CORPORATION Moncton 680186 2014 12 31 Carrot Global Canada Limited Fredericton 680189 2014 12 26 Seymour Holdings Ltd. Fredericton 680200 2014 12 29 680211 NB LTD. Grafton 680211 2014 12 29 Calumniam Consulting Inc. Fredericton 680212 2014 12 29 680214 NB Ltd. Moncton 680214 2014 12 29 680223 NB Inc. Fredericton 680223 2014 12 30 Silver Mountain Targets Inc. Keswick Ridge 680224 2014 12 30 Redgrey Consulting Inc. Fredericton 680225 2014 12 30 ALDAN Holdings Inc. Fredericton 680226 2014 12 30 680228 N.B. Inc. Saint John 680228 2014 12 30 680236 NB Inc. Fredericton 680236 2014 12 30 680237 NB Ltd. Grand Bay-Westfield 680237 2014 12 30 Kaajenga Inc. Moncton 680238 2014 12 30 Peter E. Crocco Professional Corporation Woodstock 680239 2014 12 30 680240 N.B. INC. Oak Bay 680240 2014 12 30 Advance Care Canada Limited Rothesay 680247 2014 12 30 DARCY D & D HOLDING CO. LTD. Keswick Ridge 680256 2014 12 31 Candle in the Window Primitives Inc. Boiestown 680257 2014 12 31 Oak Haven Auto Renewal Ltd. Oak Haven 680272 2014 12 31 Design Right Canada Ltd. Saint John 680278 2015 01 01 D. Armstrong Professional Corporation Fredericton 680279 2015 01 01 680280 NB Holdings (539474) Inc. Fredericton 680280 2015 01 01 Dr. Jennifer Landry Professional Corporation Saint John 680281 2014 12 31 680282 N.B. Ltd. Saint John 680282 2014 12 31 MATTHEW G. DERRAH, CPA, CA PROFESSIONAL CORPORATION Woodstock 680284 2015 01 02 The Royal Gazette — January 21, 2015 70 Gazette royale — 21 janvier 2015 MICHAEL R. CORMIER P.C. INC. Moncton 680287 2015 01 02 680295 NB Ltd. Fredericton 680295 2015 01 02 NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUM Business Corporations Act / Loi sur les corporations commerciales In relation to a certificate of incorporation issued on December 15, 2014 under the name of “Premier Shuttle Inc.”, being corporation #679961, notice is given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of incorporation correcting the name of the incorporator from “Jean Dbé” to “Jean Dubé”. Sachez que, relativement au certificat de constitution en corporation délivré le 15 décembre 2014 à « Premier Shuttle Inc. », dont le numéro de corporation est 679961, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat d’incorporation corrigé faisant passer le nom du fondateur de « Jean Dbé » à « Jean Dubé ». _____________________________________________________ In relation to a certificate of incorporation issued on December 16, 2014 under the name of “Future Bridge Inc.”, being corporation #679984, notice is given that pursuant to s. 189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of incorporation correcting the name of one of the directors from “Sonh Trinh” to “Son Trinh” and also correcting the address of another director. Sachez que, relativement au certificat de constitution en corporation délivré le 16 décembre 2014 à « Future Bridge Inc. », dont le numéro de corporation est 679984, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat d’incorporation corrigé faisant passer le nom d’un des administrateurs de « Sonh Trinh » à « Son Trinh » et corrigeant aussi l’adresse d’un des autres administrateurs. _____________________________________________________ In relation to a certificate of incorporation issued on December 16, 2014 under the name of “Prosharp Inc.”, being corporation #679985, notice is given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of incorporation correcting the “Schedule – Other Provisions / Annexe – D’autres dispositions” to the attached articles. Sachez que, relativement au certificat de constitution en corporation délivré le 16 décembre 2014 à « Prosharp Inc. », dont le numéro de corporation est 679985, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat d’incorporation corrigé corrigeant le « Schedule – Other Provisions / Annexe – D’autres dispositions » dans les articles ci-joints. _____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of continuance has been issued to: SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de prorogation a été émis à : Previous Jurisdiction Compétence antérieure Reference Number Numéro de référence Date Year Month Day année mois jour Name / Raison sociale Registered Office Bureau enregistré MARITIME BERRIES LIMITED Sackville Nouvelle-Écosse / Nova Scotia 680139 2014 12 22 IOC Oil Holdings Limited Saint John Ontario 680143 2014 12 22 MMC INSURANCE SERVICES LIMITED Moncton Nouvelle-Écosse / Nova Scotia 680146 2014 12 19 _____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of amendment has been issued to: SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de modification a été émis à : Name / Raison sociale Reference Number Numéro de référence Date Year Month Day année mois jour BRIAN HARRIS INSURANCE LTD. 007810 2014 12 23 B. & A. YOUNG LTD. 010421 2014 12 22 QUALITY SOUND ALARM LTD. 013518 2014 12 22 The Royal Gazette — January 21, 2015 71 Gazette royale — 21 janvier 2015 COX’S HOLDINGS LTD. 031202 2014 12 29 BLUECORP INC. 038434 2014 12 29 040877 N.B. LTD. 040877 2014 12 29 ROGERSVILLE ARCTIC SPORTS LTD. 041261 2014 12 30 JAMCO CONTRACTING LTD. 041337 2014 12 22 JARDINE AUCTIONEERS INC. 046222 2014 12 30 PODOCO LTEE 047938 2014 12 22 K. & I. FOOD SERVICES LTD. 052237 2014 12 19 VOLUSIA ENTERPRISES INC. 055430 2014 12 19 MIKE START HOLDINGS INC. 057995 2014 12 22 SOUTHERN SANITATION LTD 502201 2014 12 31 PROFESSIONAL QUALITY ASSURANCE LTD. 505741 2014 12 22 507877 N.B. LTD. 507877 2014 12 23 Financial Foundations Inc. 509729 2014 12 23 I. & G. Food Services Ltd. 512895 2014 12 19 Maritime Communication Services (N.B.) Ltd. 513121 2014 12 22 J.M.L. Garage Ltée 604203 2014 12 22 Place Broadway Ltée - Broadway Place Ltd. 610146 2014 12 23 CORPORATION PROFESSIONNELLE DR. PAUL LECLERC INC. 621453 2015 01 01 TOSS Architecture Inc. 622523 2014 12 22 New River Holdings Inc. 629063 2014 12 23 BASEK Hurley Holdings Ltd. 630946 2014 12 23 634939 N.B. Inc. 634939 2014 12 19 635497 N.B. Inc. 635497 2014 12 23 635498 N.B. Inc. 635498 2014 12 23 ENERCHECK SOLUTIONS INC. 636777 2014 12 23 ESR INVESTMENTS INC. 640906 2015 01 02 Assurance Sylvio Leclerc Inc. 641245 2014 12 22 K. Watt & Associates Inc. 642897 2014 12 23 Moosehead Breweries Limited 643823 2014 12 23 JOEY’S PUB & EATERY INC. 645519 2014 12 19 PVC Home Builders Ltd. 650875 2014 12 22 663683 N.B. Inc./ 663683 N.-B. Inc. 663683 2014 12 31 North of Sixty Art Ltd. 667626 2014 12 24 New Steffeshof Farms 2013 Ltd. 670028 2014 12 23 Scheele Holding Ltd. 670030 2014 12 23 673969 NB Inc. 673969 2014 12 23 The Royal Gazette — January 21, 2015 72 Gazette royale — 21 janvier 2015 D. WHALEN CONSULTING FIRM INC. 676898 2014 12 23 680076 N.B. Inc. 680076 2014 12 23 NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUM Business Corporations Act / Loi sur les corporations commerciales In relation to a certificate of amendment issued on Dcember 22, 2014 under the name of “B. & A. YOUNG LTD.”, being corporation #010421, notice is given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of amendment amending the “Schedule – Share Structure / Annexe – Organisation du capital social” to the attached articles. Sachez que, relativement au certificat de modification délivré le 22 décembre 2014 à « B. & A. YOUNG LTD. », dont le numéro de corporation est 010421, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat corrigé de modification modifiant le « Schedule – Share Structure / Annexe – Organisation du capital social » dans les articles ci-joints. _____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of amendment which includes a change in name has been issued to: SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de modification contenant un changement de raison sociale a été émis à : Name / Raison sociale Previous name Ancienne raison sociale Reference Number Numéro de référence Date Year Month Day année mois jour 22 King Street Inc. GILMAC MANAGEMENT LTD. 034221 2015 01 02 East Glassville Holdings Ltd. Calvin D. Anderson & Son Inc. 046691 2014 12 29 Steeves Porter Hetu & Associates Inc. DALE B. STEEVES PROFESSIONAL CORPORATION 059037 2014 12 23 FITSTATS TECHNOLOGIES, INC. ADVANCED FITNESS DESIGNS Inc 512670 2014 12 30 G. & S. Holdings Inc. EXCEL Pest Control LTD. 512934 2014 12 31 Bluecorp (2015) Inc. Bluecorp Realty Inc. 513252 2015 01 01 JMN ENTERPRISES INC. ATELIER LANDRY INC. 513602 2014 12 23 514313 N.B. Inc. Domaine Parlee Beach Inc. 514313 2015 01 01 TriStar Fine Cars Inc. 613735 NB INC. 613735 2015 01 01 M2 Project Builders Inc. EcoTek Homes Ltd. 631710 2014 12 29 DLN Investments Inc. Dr. Nidal Chami C.P. Inc. 650863 2014 12 22 B&J Auto Services Inc. 657565 N.B. LTD. 657565 2014 12 23 661352 N.B. LTD. OLEARY BUICK GMC LTD. 661352 2014 12 22 UWI Holdings Corporation Australian Sapphire Corporation 670570 2014 12 23 E STYLE PRO INC. Nineteen E-Cigarette & Accessories Inc. 677433 2014 12 19 McDEL LANDSCAPING AND SNOW REMOVAL CO. INC. 679321 NB Inc. 679321 2014 12 22 Shy Lady Fisheries Ltd. 679350 N.B. Ltd. 679350 2014 12 23 Hayoli Fisheries Ltd. 679359 N.B. Ltd. 679359 2014 12 29 EASTWIND BUSINESS SOLUTIONS INC. FLAGSTAFF HOLDINGS INC. 679970 2015 01 01 Campbellton Hardware Inc. MCO Holding Inc. 680133 2015 01 01 The Royal Gazette — January 21, 2015 73 Gazette royale — 21 janvier 2015 BelleBay Holdings Inc. 679710 N.B. Inc. 680159 2014 12 25 Harvey Insurance Ltd. 648490 NB Inc. 680199 2014 12 31 _____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of amalgamation has been issued to: SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de fusion a été émis à : Amalgamated Corporation Corporation issue de la fusion Amalgamating Corporations Corporations fusionnantes Registered Office Bureau enregistré Reference Number Numéro de référence Mirisa Holdings Inc. Darrell J. Stephenson Professional Corporation D.J. Stephenson P.C. Inc. Rothesay 679885 2015 01 01 Eastern Compactor Services Ltd. PENNFIELD LOGGING LTD. Eastern Compactor Services Ltd. Lutes Mountain 679945 2015 01 01 Chaisson Lemoine Professional Chaisson Lemoine Professional Corporation 679214 N.B. Inc. Saint John 679969 2014 12 31 FLAGSTAFF HOLDINGS INC. Eastwind Business Solutions Inc. FLAGSTAFF HOLDINGS INC. Petitcodiac 679970 2015 01 01 ANDRITZ HYDRO CANADA INC. Andritz Hydro Canada Inc. Saint John Andritz Hydro Ltée./Andritz Hydro Ltd. 680030 2015 01 01 ÉPICERIE LEBRETON (2014) LTÉE Epicerie LeBreton 1998 Ltée 679605 NB INC. Shippagan 680031 2014 12 31 649850 N.B. Ltd. 051536 N. B. LTD. 649850 N.B. Ltd. Moncton 680044 2015 01 01 GENERAL FINANCIAL CORPORATION LTD. 514313 N.B. Inc. 602867 N.B. LTD. GENERAL FINANCIAL CORPORATION LTD. Shediac 680048 2015 01 01 Jean-Marc Gauvin C.P. Inc. GO-20 INC. 059892 NB Inc. Jean-Marc Gauvin C.P. Inc. Saint-Simon 680068 2015 01 01 FPM HOLDING INC. CLARENCE DAIGLE & FILS LTEE - Edmundston CLARENCE DAIGLE & SONS LTD. J.J. CONSTRUCTION & LEASING CO. LTD. FPM HOLDING INC. 680082 2015 01 01 MONCTON FISH MARKET LTD. MONCTON FISH MARKET LTD. 629697 N.B. Inc. 629700 N.B. Inc. Moncton 680083 2014 12 23 R. & D. ENTERPRISES LTD. R. & D. ENTERPRISES LTD. 679835 NB INC. Campbellton 680090 2015 01 01 Irving Consumer Products Limited Les Produits de Consommation Irving Limitée Irving Tissue Corporation Les Papiers Irving Incorporée Irving Personal Care Limited Les Soins Personnels Irving Limitée Irving Consumer Products Limited Les Produits de Consommation Irving Limitée Saint John 680104 2015 01 01 Coast Tire & Auto Service Ltd. COAST TIRE (FAIRVILLE BLVD.) LTD. Coast Tire & Auto Service Ltd. Saint John 680114 2015 01 01 Date Year Month Day année mois jour The Royal Gazette — January 21, 2015 74 Gazette royale — 21 janvier 2015 MCO Holding Inc. MCO HOLDING INC. CAMPBELLTON HARDWARE INC. Campbellton 680133 2015 01 01 LA CAUSERIE AMICALE INC. Sunflower Patch Daycare Inc. / Garderie Jardin de Tournesols Inc. Friendship Circle DayCare Inc. / Garderie Le Cercle d’Amitié Inc. La Causerie Amicale Inc. Cocagne 680135 2015 01 01 R & D Zinck Holdings Ltd. 501932 N.B. Inc. R & D ZINCK HOLDINGS LTD. CTB Holdings Ltd. 649103 N.B. Inc. McLeod Hill 680140 2015 01 01 SNOKIST LTD. PRYOR FARMS LTD. SNOKIST LTD. Hartford 680145 2015 01 01 679710 N.B. Inc. BelleBay Holdings Inc. 679710 N.B. Inc. Saint John 680159 2014 12 25 Family First Human Services Inc. FAMILY FIRST HUMAN SERVICES INC. 674027 N.B. Inc. Richibucto Road 680168 2015 01 01 Matt Holdings Ltd. M.F. ESSON & SONS, LIMITED MATT HOLDINGS LTD. Hanwell 680187 2015 01 01 Max Health Institute and Physiotherapy P.C. Inc./ Institut de la santé Max et physiothérapie c.p. inc. MAX Health Institute Inc. / Institut de santé Max inc. Max Health Institute and Physiotherapy P.C. Inc./ Institut de la santé Max et physiothérapie c.p. inc. Dieppe 680194 2015 01 01 ASSURANCE VIENNEAU LTEE VIENNEAU INSURANCE LTD. ASSURANCE VIENNEAU LTEE VIENNEAU INSURANCE LTD. Assurance Beauséjour Insurance Ltée. - Assurance Beauséjour Insurance Ltd. Shediac 680195 2015 01 01 607198 N.B. LTD. 607198 N.B. LTD. 658229 N.B. INC. Bethel 680198 2015 01 01 648490 NB Inc. HARVEY INSURANCE LTD. 648490 NB Inc. Harvey Station 680199 2014 12 31 Power Engineers Canada, Inc. Power Food Consulting, Inc. Power Engineers Canada, Inc. Fredericton 680203 2015 01 01 C.J. Poirier Entreprises Ltée PODOCO LTEE C.J. POIRIER ENTREPRISES LTÉE Grand-Barachois 680230 2015 01 01 SHEPODY BERRY & LUMBER, CO. LTD. SACKVILLE MEDICAL REALTIES Sackville LTD. SHEPODY BERRY & LUMBER, CO., LTD. MARITIME BERRIES LIMITED 680231 2015 01 01 629856 N.B. Ltd. 629856 N.B. LTD. 654845 N.B. Ltd. 654847 N.B. Ltd. Moncton 680232 2014 12 31 Scan Air Balance (1998) Ltd. Scan Air Balance (1998) Ltd. 661252 NB LTD. Moncton 680233 2015 01 01 David McCarthy Ltd. DAVID MCCARTHY LTD. Ebbett Farms Limited Upper Kent 680234 2015 01 01 On The Trail Adventures Ltd. Northway Outfitters Ltd. On The Trail Adventures Ltd. Windsor 680235 2015 01 01 The Royal Gazette — January 21, 2015 75 Gazette royale — 21 janvier 2015 BACK BAY SALMON LTD. BACK BAY SEA URCHINS LTD. BACK BAY SALMON LTD. Back Bay 680244 2015 01 01 Xplornet Communications Inc. Xplornet Broadband Inc. 632527 New Brunswick Inc. Xplornet Communications Inc. Woodstock 680246 2015 01 01 Lounsbury Company Limited Lucien LeBlanc Holdings Inc. Lounsbury Company Limited Moncton 680250 2015 01 01 Lounsbury Company Limited C. H. S. Holdings Inc. Lounsbury Company Limited Moncton 680251 2015 01 01 New Brunswick EMS Inc. BLUECORP INC. New Brunswick EMS Inc. MMC INSURANCE SERVICES LIMITED Moncton 680253 2015 01 01 CRESCENT (1952) LIMITED CRESCENT (1952) LIMITED 667090 NB LTD. Hartland 680254 2015 01 01 Omer LeBlanc & Son Ltd./Ltée OMER LEBLANC & SON LTD/LTEE Dalhousie MARITIME ROOF SYSTEMS LTD./ SYSTEME DE TOIT MARITIME LTEE. 680260 2015 01 01 HOWLAND HOLDINGS LTD. HOWLAND HOLDINGS LTD. BELLEISLE LEASING LTD. Quispamsis 680262 2014 12 31 Charles & Marthe Investments Inc. Pharmacie Richard Pharmacy Inc. Charles & Marthe Investments Inc. Saint-Louis-deKent 680263 2015 01 01 G. Lemieux & A. Ménard P.C. Inc. J. Gilles Lemieux Corporation Professionnelle Inc./ Professional Corporation Alison J. Ménard P.C. Inc. Saint-Antoine 680264 2015 01 01 CFMO Company Limited CFMO Company Limited CFME Company Limited IOC Oil Holdings Limited Saint John 680266 2015 01 01 Brett Chevrolet Cadillac Buick 058928 N.B. INC. Brett Chevrolet Cadillac Buick GMC Ltd. Saint John 680269 2015 01 01 056632 N.B. LTD. 056632 N.B. LTD. Saint John Auto Auction Ltd. 653760 N.B. INC. 661765 N.B. Ltd. Rusagonis 680270 2015 01 01 Briggs & Little Woolen Mills Ltd. BRIGGS & LITTLE WOOLEN MILLS Harvey LTD. JOHN LITTLE HOLDINGS LTD. 680271 2015 01 01 Restigouche Court Development Inc. RESTIGOUCHE COURT DEVELOPMENT INC. Maximum Paving Inc. Campbellton 680274 2015 01 01 Meubles J.R. Lagacé Inc. Meubles J.R. Lagacé Inc. MEUBLES EKO FURNITURE INC. Campbellton 680276 2015 01 01 RIJON INVESTMENTS LTD. RIJON INVESTMENTS LTD. JONRI MANAGEMENT LTD. Saint John 680285 2015 01 02 _____________________________________________________ The Royal Gazette — January 21, 2015 76 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of dissolution has been issued to: Gazette royale — 21 janvier 2015 SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de dissolution a été émis à : Registered Office Bureau enregistré Reference Number Numéro de référence Date Year Month Day année mois jour COASTAL CANADA PETROLEUM, INC. PETROLE COASTAL CANADA, INC. Saint John 057264 2014 12 19 Sterling Electronic Commerce (Canada), Inc./ Commerce Electronique Sterling (Canada) Inc. Saint John 608455 2014 12 30 Dollarama Corporation Saint John 615595 2014 12 18 W. E. P. Edwards Consulting Solutions Inc. Saint John 636383 2014 12 29 R.A. Soucy Consultants Inc. Edmundston 638626 2014 12 19 JOHNSTON’S TOWING & RECOVERY INC. Sussex Corner 644060 2014 12 31 Apex Tool Holding Canada 3 Ltd. Saint John 651136 2014 12 31 Dre Nadine Kabwe Kiti C.P. Inc. Edmundston 659435 2014 12 19 Name / Raison sociale _____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a restated certificate of incorporation has been issued to: SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de constitution mise à jour a été émis à : Name / Raison sociale T.M.M. Fabrication Inc. Reference Number Numéro de référence Date Year Month Day année mois jour 047026 2014 12 22 _____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, notice of the discharge of a receiver or a receivermanager of the following corporations has been received: SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un avis de libération d’un séquestre ou séquestre-gérant pour les sociétés suivantes a été reçu : Name / Raison sociale Registered Office Bureau enregistré Receiver or Receiver-Manager Séquestre ou séquestre-gérant Reference Number Numéro de référence Date Year Month Day année mois jour Pneus ABC Tires Inc. Atholville POWELL ASSOCIATES LTD. 621674 2014 12 22 _____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of discontinuance has been issued to: SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de cessation a été émis à : Name / Raison sociale Jurisdiction of Continuance Compétence de prorogation Reference Number Numéro de référence Date Year Month Day année mois jour Distribution 83 PPM Inc. Québec / Quebec 514356 2014 12 22 THE NIGHT SHIFT ANSWERING SERVICE LTD. Colombie-Britannique / British Columbia 626338 2014 12 12 PT Health NB Professional Corporation Canada 662997 2014 12 11 _____________________________________________________ The Royal Gazette — January 21, 2015 77 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of revival has been issued to: Gazette royale — 21 janvier 2015 SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de reconstitution a été émis à : Name / Raison sociale Reference Number Numéro de référence Date Year Month Day année mois jour BILL A’COURT SALES LTD. 501819 2014 12 22 Hugh Investment Group Corporation 611487 2014 12 23 Ray of Light Daycare Inc. 660606 2014 12 22 _____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of registration of extra-provincial corporation has been issued to: Name / Raison sociale Jurisdiction Compétence ANDREW ROBERTS PROFESSIONAL Canada CORPORATION LTD. SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat d’enregistrement de corporation extraprovinciale a été émis à : Agent and Address Représentant et adresse Andrew D.W. Roberts Moncton Reference Number Numéro de référence Date Year Month Day année mois jour 680045 2014 12 18 ALTIUS RESOURCES INC. Terre-Neuve et Labrador/ McInnes Cooper Newfoundland and CSD Services Inc. Labrador Fredericton 680103 2014 12 19 Escalade Wines & Spirits Inc. Ontario Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc. Saint John 680113 2014 12 22 9108483 Canada Inc. Canada Donald J. Stevenson Fredericton 680130 2014 12 22 Fjallraven USA, LLC New York Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc. Saint John 680156 2014 12 23 9122800 Canada Inc. Canada Trevor Cookson Fredericton 680178 2014 12 23 GGR Finance Inc. Ontario Jay Phinney Saint John 680196 2014 12 29 Eckler Ltd./Eckler ltée Ontario Arthur T. Doyle Saint John 680197 2014 12 29 ENTREPRISES JOCELYNE FAUVEL INC. Canada Jocelyne Fauvel Pointe-Alexandre 680204 2014 12 29 9116869 Canada Corporation Canada René Basque Moncton 680210 2014 12 29 _____________________________________________________ The Royal Gazette — January 21, 2015 78 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of amendment of registration of extraprovincial corporation has been issued to: Gazette royale — 21 janvier 2015 SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de modification de l’enregistrement de corporation extraprovinciale a été émis à : Name / Raison sociale Previous name Ancienne raison sociale Reference Number Numéro de référence Date Year Month Day année mois jour IRI-Aztec (Canada) Ltd. Aztec Information Services (Canada) Limited 672195 2014 12 23 _____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of registration of amalgamated corporation has been issued to the following extra-provincial corporations: SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat d’enregistrement d’une corporation extraprovinciale issue de la fusion a été émis aux corporations extraprovinciales suivantes : Agent and Address Représentant et adresse Reference Number Numéro de référence Date Year Month Day année mois jour Amalgamated Corporation Corporation issue de la fusion Amalgamating Corporations Corporations fusionnantes MGA Partners Inc. MGA Partners Inc. Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc. Saint John 680022 2014 12 17 MGA Partners Inc. MGA Partners Inc. Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc. Saint John 680023 2014 12 17 SLEEMAN BREWERIES LTD./ BRASSERIE SLEEMAN LTEE SLEEMAN BREWERIES LTD. BRASSERIE SLEEMAN LTEE Willard M. Jenkins Saint John 680220 2014 12 29 Companies Act Loi sur les compagnies PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act, letters patent have been granted to: SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres patentes ont été émises à : Name / Raison sociale Head Office Siège social Reference Number Numéro de référence Date Year Month Day année mois jour Santélo Inc. Edmundston 680089 2014 12 19 FRIENDS OF KENNEBECASIS VALLEY LIBRARY INC. Quispamsis 680172 2014 12 23 The Royal Gazette — January 21, 2015 79 Gazette royale — 21 janvier 2015 Partnerships and Business Names Registration Act Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of business name has been registered: SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat d’appellation commerciale a été enregistré : Registrant of Certificate Enregistreur du certificat Address of Business or Agent Adresse du commerce ou du représentant Reference Number Numéro de référence Date Year Month Day année mois jour Crafts Trucking Thomas M. Craft Saint John 679532 2014 11 19 Matrix North American Construction Matrix SME Canada ULC Saint John 679954 2015 01 01 You-Mist-It Vape Store Sophia Macleod Moncton 679976 2014 12 16 Vacation Express Canada Sunwing Vacations Inc./ Vacances Sunwing Inc. Saint John 680000 2014 12 17 The Blake Wealth Management Group Dundee Securities Ltd./ Valeurs Mobilieres Dundee ltee Saint John 680007 2014 12 17 Forgeron Régis Haché Régis Haché Losier Settlement 680033 2014 12 17 SMS Ventilation Shirley Morin Saint-Joseph 680035 2014 12 29 Inn Thyme Lodging 678836 NB Inc. Shediac 680046 2014 12 18 Auberge Inn Thyme 678836 NB Inc. Shediac 680047 2014 12 18 Atlantic Quality & Technical Services Atlantic Quality & Technical Services Inc. Les Services Techniques & De Qualité Atlantiques Inc. Saint John 680062 2014 12 18 SYNERGY DESIGNS GRAYSIA WEB SITE DESIGN AND VIRTUAL ASSISTANT SERVICES INC. Sussex 680063 2014 12 18 Signature Pre-Owned Auto Gallery 045502 N. B. LTD. Saint John 680065 2014 12 18 Maritime Oysters N.B. M.R. JAILLET ENTERPRISES INC. Saint-Joseph-de-Kent 680066 2014 12 18 Doctor’s Orders: Rehabilitation Canes 676855 New Brunswick Inc. Fredericton 680067 2014 12 18 Andrew C Electric Heather Long Riverview 680075 2014 12 18 DOYEN TECHNICAL Pragmantis Group Inc. Saint John 680091 2014 12 19 PATRICK RICHARDS PHOTOGRAPHY Pragmantis Group Inc. Saint John 680092 2014 12 19 Kira M Painting Kira McLean Fredericton 680098 2014 12 20 Chaleur Shamrock East/West Applications Ray Ed Dawson Dalhousie 680099 2014 12 20 HughGarse FoodTruck Kevin Robert Salisbury 680100 2014 12 20 Les Produits de Consommation Irving Irving Consumer Products Limited Les Produits de Consommation Irving Limitée Dieppe 680105 2015 01 01 Name / Raison sociale The Royal Gazette — January 21, 2015 80 Gazette royale — 21 janvier 2015 Irving Consumer Products Irving Consumer Products Limited Les Produits de Consommation Irving Limitée Dieppe 680106 2015 01 01 Les Soins Personnels Irving Irving Consumer Products Limited Les Produits de Consommation Irving Limitée Dieppe 680107 2015 01 01 Irving Personal Care Irving Consumer Products Limited Les Produits de Consommation Irving Limitée Dieppe 680109 2015 01 01 Laqua Holdings Stephan Laqua Saint-Edouard-de-Kent 680118 2014 12 22 Jesters Tactical Sports Center Nathan Den Hollander Lincoln 680120 2014 12 22 Craft General Contracting Thomas Craft Saint John 680121 2014 12 22 Courtside Sneakers 9108483 Canada Inc. Fredericton 680131 2014 12 22 TOWNE AUTO CENTER Towne Sales and Service Limited Napan 680136 2014 12 22 Kelly L. Buffett Law Office Kelly Buffett Fredericton 680151 2014 12 23 Fredericton Hyundai 679604 N.B. Ltd. Fredericton 680157 2014 12 23 OLeary Buick GMC 679603 N.B. Ltd. Fredericton 680158 2014 12 23 Ashford Auto Body Rodney Ashford Berry Mills 680175 2014 12 23 Evergreen Traders Trevor Rivett Fredericton 680185 2014 12 24 Dooly’s Sports Bar II 505342 N.B. LTD. Fredericton 680190 2014 12 29 Your Ideal Weigh 677858 N.B. Corp. Fredericton 680206 2014 12 29 CR Yardworks & Equipment Brandon Cox Riverview 680217 2014 12 29 Costello’s Plumbing & Heating Derrick Costello Miramichi 680219 2015 01 01 STROH BREWERY SLEEMAN BREWERIES LTD./ BRASSERIE SLEEMAN LTEE Saint John 680221 2014 12 29 SLEEMAN UNIBROUE SLEEMAN BREWERIES LTD./ BRASSERIE SLEEMAN LTEE Saint John 680222 2014 12 29 Rodolphe Monette Psychologue Rodolphe Monette Dieppe 680241 2014 12 31 IMB Apparel Sajid Butt Quispamsis 680255 2014 12 31 Lemieux Ménard & Co. G. Lemieux & A. Ménard P.C. Inc. Saint-Antoine 680265 2015 01 01 FANCY COFFEE SERVICES Frederick A. Dixon Florenceville-Bristol 680273 2014 12 23 Maximum Paving Restigouche Court Development Inc. Campbellton 680275 2015 01 01 Meubles EKO Furniture Meubles J.R. Lagacé Inc. Atholville 680277 2015 01 01 Ironstone Enterprises Bradley Gillcash Dundas 680283 2015 01 02 The Royal Gazette — January 21, 2015 81 Gazette royale — 21 janvier 2015 NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUM Partnerships and Business Names Registration Act / Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales In relation to the certificate of business name registered on December 14, 2014 under the Act, under the name of “The Urban Nest Gifts & Decor”, being file #679948, notice is given that pursuant to s.17 of the Act, the Registrar has ordered that the address at section 6 be corrected to read as follows: “Douglastown Plaza, 3 Renaud Street, Miramichi, NB”. Sachez que, relativement à un certificat d’appellation commerciale enregistré le 14 décembre 2014 en vertu de la Loi sous le nom de « The Urban Nest Gifts & Decor », dont le numéro d’appellation commerciale est 679948, le registraire a ordonné, conformément à l’article 17 de la Loi, que l’adresse à la section 6 soit corrigée pour qu’elle se lise comme suit : « Douglastown Plaza, 3 Renaud Street, Miramichi, NB ». _____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of renewal of business name has been registered: SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de renouvellement d’appellation commerciale a été enregistré : Name / Raison sociale Registrant of Certificate Enregistreur du certificat Address of Business or Agent Adresse du commerce ou du représentant Reference Number Numéro de référence Date Year Month Day année mois jour MOUNTAIN MAPLES Leslie C. Stiles Elgin 319142 2015 01 01 SLEEMAN BREWING & MALTING SLEEMAN BREWERIES LTD./ CO. BRASSERIE SLEEMAN LTEE Saint John 347657 2014 12 29 STROH CANADA SLEEMAN BREWERIES LTD./ BRASSERIE SLEEMAN LTEE Saint John 347762 2014 12 29 IRVING TISSUE Irving Consumer Products Limited Les Produits de Consommation Irving Limitée Dieppe 350888 2015 01 01 IRVING TISSUE COMPANY Irving Consumer Products Limited Les Produits de Consommation Irving Limitée Saint John 350889 2015 01 01 Sussex Towing 504741 N.B. LTD. Passekeag 609318 2014 12 19 Les Papiers Irving Irving Consumer Products Limited Les Produits de Consommation Irving Limitée Dieppe 609364 2015 01 01 GNR Sales & Service Gabriel Cormier Irishtown 610248 2014 12 17 VALLEY CLEANERS Mark Wayne Hovey Valley Road 610511 2014 12 18 Jessica Rhaye Music Jessica Grimmer Hampton 610521 2014 12 18 DEWITT LINGUISTIC SERVICES Steven Dewitt Fredericton 610552 2014 12 22 SLEEMAN MARITIMES SLEEMAN BREWERIES LTD./ BRASSERIE SLEEMAN LTEE Saint John 611699 2014 12 29 Fireball Gallery & Studio D. Lynne Bowland Lord’s Cove 615858 2014 12 27 BEAULIEU ALUMINIUM GROUPE DEAN DAIGLE GROUP INC. Edmundston 616026 2014 12 23 RED BULL BEER COMPANY SLEEMAN BREWERIES LTD./ BRASSERIE SLEEMAN LTEE Saint John 622350 2014 12 29 Roy Auto St-Quentin Joël Roy Saint-Quentin 629980 2014 12 30 Ecole DansEncorps School Chantal Cadieux Moncton 645712 2014 12 22 Around the Block Contracting Michael Parker Weldon 646445 2014 12 19 JONES GALLERY Sarah Jones Saint John 647031 2014 12 30 The Royal Gazette — January 21, 2015 82 Gazette royale — 21 janvier 2015 Le Festival de Canneberge du Canada Atlantique Village de Rogersville Rogersville 647032 2014 12 23 Festival de la Récolte Canneberge à Rogersville Village de Rogersville Rogersville 647033 2014 12 23 Célébration de la Récolte des canneberges Village de Rogersville Rogersville 647034 2014 12 23 Capital City Toy Store 645062 NB Inc. Hanwell 647121 2014 12 19 The Raven’s Tree Natural Body Soaps & Creams Ramona Leduc Rusagonis 647756 2014 12 24 DON’S AUTO REPAIR AND SERVICE Donald LeBlanc Memramcook 648044 2014 12 29 COLES INDIGO BOOKS & MUSIC INC. Fredericton 648050 2014 12 16 Sodexo Services Canada Sodexo Canada Ltd. Saint John 648998 2014 12 22 STEP UP FOR LIFE MONCTON CRISIS PREGNANCY CENTRE, INC. Moncton 649373 2014 12 18 _____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of cessation of business or use of business name has been registered: SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessation de l’activité ou de cessation d’emploi de l’appellation commerciale a été enregistré : Address / Adresse Reference Number Numéro de référence Date Year Month Day année mois jour STEEVES PORTER HE’TU Rothesay 348564 2014 12 23 Fredericton Hyundai Fredericton 609638 2014 12 22 TRI STAR FINE CARS Saint John 614095 2015 01 01 B&J AUTO SERVICES Dalhousie 621293 2014 12 23 Fancy Coffee Services Riverbank 622072 2014 12 23 THERRIEN FABRICATION Edmundston 625768 2014 12 23 HOLIDAY RESTAURANT Cambridge-Narrows 627900 2014 12 18 Down East Window & Door Sussex 643902 2014 12 23 Candle in the window primitives Boiestown 655654 2014 12 31 O’LEARY AUTO GROUP Fredericton 664093 2014 12 22 Boutique Bébé tout neuf Tracadie-Sheila 664577 2014 12 31 Your Ideal Weigh Fredericton 667771 2014 12 29 Design Right Canada Saint John 674790 2015 01 01 A.W.O.L. Brewery Riverview 675208 2014 12 22 Newmarket Forest Ventures Newmarket 675713 2014 12 31 Bronsage ZANA Kedgwick 679406 2014 12 23 Name / Raison sociale The Royal Gazette — January 21, 2015 83 Gazette royale — 21 janvier 2015 D.S. Forma-Soins Edmundston 679734 2014 12 18 The Urban Nest Gifts & Decor Miramichi 679948 2014 12 29 _____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of change of agent for service has been registered: SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de changement d’un représentant pour fin de signification a été déposé : Agent and Address / Représentant et adresse Name / Raison sociale Indigo Michael Connors Fredericton Reference Number Numéro de référence Date Year Month Day année mois jour 638727 2014 12 16 _____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of partnership has been registered: SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de société en nom collectif a été enregistré : Address of Business or Agent Adresse du commerce ou du représentant Reference Number Numéro de référence Date Year Month Day année mois jour Name / Raison sociale Partners / Membres East Coast Beef Jerky Tracey Johnston Randy Johnston Sackville 679870 2014 12 19 D.S. Forma-Soins Sylvie Gaumont Denis Chouinard Edmundston 680060 2014 12 18 The Urban Nest Gifts & Decor Laura St. Coeur Wade St. Coeur Miramichi 680191 2014 12 29 _____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of renewal of partnership has been registered: Name / Raison sociale CROSSFIT SAINT JOHN Partners / Membres Michael Jackson Amy Wilkins SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de renouvellement de société en nom collectif a été enregistré : Address of Business or Agent Adresse du commerce ou du représentant Reference Number Numéro de référence Date Year Month Day année mois jour Saint John 646912 2014 _____________________________________________________ 12 18 The Royal Gazette — January 21, 2015 84 Gazette royale — 21 janvier 2015 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of dissolution of partnership has been registered: SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de dissolution de société en nom collectif a été enregistré : Address / Adresse Reference Number Numéro de référence Date Year Month Day année mois jour Lemieux Ménard & Co. Saint-Antoine 666665 2014 12 31 J and R Cleaning Service Fredericton 676965 2014 12 31 Name / Raison sociale Limited Partnership Act Loi sur les sociétés en commandite PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partnership Act, a declaration of limited partnership has been filed by: SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une déclaration de société en commandite a été déposée par : Name / Raison sociale General Partners Commandités Principal place in New Brunswick Principal établissement au Nouveau-Brunswick Reference Number Numéro de référence Date Year Month Day année mois jour ENBRIDGE GAS NEW BRUNSWICK LIMITED PARTNERSHIP Enbridge Gas New Brunswick Inc./ Enbridge Gaz NouveauBrunswick Fredericton 400538 2014 12 22 Agartis LP Tortora, Julien F.R. Saint John 680173 2014 12 23 _____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partnership Act, a declaration of extra-provincial limited partnership has been filed: SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une déclaration de société en commandite extraprovinciale a été déposée par : Principal place in New Brunswick Principal établissement au Nouveau-Brunswick Reference Number Numéro de référence Jurisdiction Compétence Date Year Month Day année mois jour Trimac Transportation Services Limited Partnership Saint John Alberta Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc. Saint John 616032 2014 12 22 DOLLARAMA L.P. -DOLLARAMA S.E.C. Saint John Québec / Quebec Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc. Saint John 616403 2014 12 17 Marketwired Holding L.P. Saint John Manitoba Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc. Saint John 675396 2014 12 23 Marketwired L.P. Saint John Ontario Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc. Saint John 680155 2014 12 23 Name / Raison sociale Agent and Address Représentant et adresse _____________________________________________________ The Royal Gazette — January 21, 2015 85 Gazette royale — 21 janvier 2015 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partnership Act, a declaration of extra-provincial limited partnership, which includes a name change, has been filed: SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une déclaration de société en commandite extraprovinciale, contenant une nouvelle raison sociale, a été déposée par : Name / Raison sociale Previous Name Ancienne raison sociale Jurisdiction Compétence Marketwired Holding L.P. Marketwire L.P. Manitoba Agent and Address Représentant et adresse Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc. Saint John Reference Number Numéro de référence Date Year Month Day année mois jour 675396 2014 12 23 _____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partnership Act, a declaration of withdrawal of extra-provincial limited partnership has been filed: SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une déclaration de retrait de société en commandite extraprovinciale a été déposée par : Agent and Address Représentant et adresse Jurisdiction Compétence Name / Raison sociale MARRET HIGH GRADE HEDGE LIMITED Ontario PARTNERSHIP Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc. Saint John Reference Number Numéro de référence Date Year Month Day année mois jour 648101 2014 12 24 _____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partnership Act, a declaration of change of limited partnership or extraprovincial limited partnership has been filed: SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une déclaration de changement de société en commandite ou de société en commandite extraprovinciale a été déposée : Name / Raison sociale Jurisdiction Compétence General Partners Commandités Marketwired Holding L.P. Ontario Marketwired Canada Limited Principal place in New Brunswick Principal établissement au Nouveau-Brunswick Reference Number Numéro de référence Date Year Month Day année mois jour Saint John 675396 2014 12 23 Department of Transportation and Infrastructure Ministère des Transports et de l’Infrastructure NOTICE OF SALE FOR REMOVAL Camp Lot 1 Black Top Mountain Group Off Charlo Road, Black Top Mountain Restigouche County, N.B. One storey camp on Lot 1, Black Top Mountain Group, off Charlo Road, Black Top Mountain, Restigouche County, N.B. For inspection, contact Natural Resources’ Campbellton Office, at 506-789-2336. Refer to Tender No. 15-L0045 on all communications. A property value of $500 has been placed on this asset. AVIS DE VENTE ET D’ENLÈVEMENT Camp Lot 1 Groupe du Mont Black Top En retrait du chemin Charlo, Black Top Mountain Comté de Restigouche (N.-B.) Camp d’un étage situé sur lot 1, groupe du Mont Black Top, en retrait du chemin Charlo, Black Top Mountain, comté de Restigouche (N.-B.). Pour l’inspection, communiquer avec le bureau du ministère des Ressources naturelles de Campbellton, au 506-789-2336. Mentionner l’appel d’offres no 15-L0045 dans toutes les communications. La valeur du bien est de 500 $. The Royal Gazette — January 21, 2015 86 Gazette royale — 21 janvier 2015 The purchaser may within 14 days from the date of receiving a bill of sale, make application to the Department of Natural Resources for a recreational camp lot lease. Dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception de l’acte de vente, l’acheteur peut faire une demande au ministère des Ressources naturelles pour un bail de lieu de camp. Property Value: $500 Closing Date: January 26, 2015 Valeur du bien : 500 $ Date de fermeture : le 26 janvier 2015 For tender submission criteria, Visit: www.GNB.ca/2221 Call: 506-453-2221 E-mail: pearl.black@gnb.ca Reference: Tender No.: 15-L0045 Pour les conditions de soumission : http://www.gnb.ca/2221/index-f.asp Appeler : 506-453-2221 Par courriel : pearl.black@gnb.ca Mentionner : l’appel d’offres no 15-L0045 Hon. Roger Melanson Minister of Transportation and Infrastructure Le ministre des Transports et de l’Infrastructure L’Hon. Roger Melanson Notices of Sale Avis de vente Sale of Lands Publication Act R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2) To: Wendell Philip Morris, original Mortgagor and owner of the equity of redemption; and to all others whom it may concern. Sale pursuant to terms of the mortgage and the Property Act, R.S.N.B. 1973, c.P-19, as amended. Freehold property situate at 104 Islandview Drive, Miramichi, in the County of Northumberland and Province of New Brunswick, and being identified as PID 40220915. Notice of Sale given by The Toronto-Dominion Bank, Mortgagee and holder of the mortgage. Sale to be held at the Miramichi Law Courts, 673 King George Highway, Miramichi, New Brunswick on Thursday, January 29, 2015, at the hour of 11:00 a.m., local time. See advertisement of Notice of Mortgage Sale in the Miramichi Leader dated December 31, 2014, January 7, January 14, and January 21, 2015. Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces L.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2) Destinataire : Wendell Philip Morris, débiteur hypothécaire originaire et propriétaire du droit de rachat; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenure libre situés au 104, promenade Islandview, à Miramichi, comté de Northumberland, province du NouveauBrunswick, et ayant le NID 40220915. Avis de vente donné par la Banque Toronto-Dominion, créancière hypothécaire et titulaire de l’hypothèque. La vente aura lieu le jeudi 29 janvier 2015, à 11 h, heure locale, au palais de justice de Miramichi, 673, route King George, Miramichi (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions du 31 décembre 2014 et des 7, 14 et 21 janvier 2015 du Miramichi Leader. McInnes Cooper, Solicitors for The Toronto-Dominion Bank, Per: Natalie M. Stewart, Suite 1700, Brunswick Square, 1 Germain Street, P.O. Box 6370, Saint John, New Brunswick, E2L 4R8, Telephone: 506-643-6500, Facsimile: 506-643-6505 Natalie M. Stewart, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Banque Toronto-Dominion, Brunswick Square, bureau 1700, 1, rue Germain, C.P. 6370, Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 4R8; téléphone : 506-643-6500; télécopieur : 506-643-6505 ________________ ________________ TO: NANCY DOREEN McKAY, of 128 Demille Court, Hampton, New Brunswick, E5N 2E4, Mortgagor; DESTINATAIRES : NANCY DOREEN McKAY, du 128, cour Demille, à Hampton (Nouveau-Brunswick), E5N 2E4, débitrice hypothécaire; BANQUE ROYALE DU CANADA, 100, rue King, Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 1G4, créancière hypothécaire; ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL. Lieux en tenure libre situés au 50-54, rue Waterloo, à Saint John (Nouveau-Brunswick), paroisse de Saint John, comté de Saint John, province du Nouveau-Brunswick, dont le NID est 13847. Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulaire de la première hypothèque. AND TO: ROYAL BANK OF CANADA, 100 King Street, Saint John, New Brunswick, E2L 1G4, Mortgagee; AND TO: ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN. Freehold premises situate, lying and being at 50-54 Waterloo Street, Saint John, New Brunswick, in the Parish of Saint John, County of Saint John, and Province of New Brunswick, also known as PID 13847. Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of the first mortgage. The Royal Gazette — January 21, 2015 87 Gazette royale — 21 janvier 2015 Sale on the 19th day of February, 2015, at 11:00 a.m., at the Saint John County Registry Office at 2nd Floor, 15 King Square North, Saint John, New Brunswick. The Mortgagee reserves the right to postpone or reschedule the time and date of sale. See advertisement in the Telegraph-Journal. La vente aura lieu le 19 février 2015, à 11 h, au bureau de l’enregistrement du comté de Saint John situé au 15, King Square Nord, 2e étage, Saint John (Nouveau-Brunswick). La créancière hypothécaire se réserve le droit de reporter la date et l’heure de la vente. Voir l’annonce publiée dans le Telegraph-Journal. Cox & Palmer, Solicitors for the Mortgagee, the Royal Bank of Canada Cox & Palmer, avocats de la créancière hypothécaire, la Banque Royale du Canada ________________ ________________ TO: NANCY DOREEN McKAY, of 128 Demille Court, Hampton, New Brunswick, E5N 2E4, Mortgagor; DESTINATAIRES : NANCY DOREEN McKAY, du 128, cour Demille, à Hampton (Nouveau-Brunswick), E5N 2E4, débitrice hypothécaire; BANQUE ROYALE DU CANADA, 100, rue King, Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 1G4, créancière hypothécaire; ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL. Lieux en tenure libre situés au 50-54, rue Wright, à Saint John (Nouveau-Brunswick), paroisse de Saint John, comté de Saint John, province du Nouveau-Brunswick, dont le NID est 55197511. Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulaire de la première hypothèque. La vente aura lieu le 19 février 2015, à 11 h 15, au bureau de l’enregistrement du comté de Saint John situé au 15, King Square Nord, 2e étage, Saint John (Nouveau-Brunswick). La créancière hypothécaire se réserve le droit de reporter la date et l’heure de la vente. Voir l’annonce publiée dans le TelegraphJournal. AND TO: ROYAL BANK OF CANADA, 100 King Street, Saint John, New Brunswick, E2L 1G4, Mortgagee; AND TO: ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN. Freehold premises situate, lying and being at 50-54 Wright Street, Saint John, New Brunswick, in the Parish of Saint John, County of Saint John, and Province of New Brunswick, also known as PID 55197511. Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of the first mortgage. Sale on the 19th day of February, 2015, at 11:15 a.m., at the Saint John County Registry Office at 2nd Floor, 15 King Square North, Saint John, New Brunswick. The Mortgagee reserves the right to postpone or reschedule the time and date of sale. See advertisement in the Telegraph-Journal. Cox & Palmer, Solicitors for the Mortgagee, the Royal Bank of Canada Cox & Palmer, avocats de la créancière hypothécaire, la Banque Royale du Canada ________________ ________________ TO: NANCY DOREEN McKAY, of 128 Demille Court, Hampton, New Brunswick, E5N 2E4, Mortgagor; DESTINATAIRES : NANCY DOREEN McKAY, du 128, cour Demille, à Hampton (Nouveau-Brunswick), E5N 2E4, débitrice hypothécaire; BANQUE ROYALE DU CANADA, 100, rue King, Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 1G4, créancière hypothécaire; ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL. Lieux en tenure libre situés au 102, rue Carleton, à Saint John (Nouveau-Brunswick), paroisse de Saint John, comté de Saint John, province du Nouveau-Brunswick, dont le NID est 38133. AND TO: ROYAL BANK OF CANADA, 100 King Street, Saint John, New Brunswick, E2L 1G4, Mortgagee; AND TO: ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN. Freehold premises situate, lying and being at 102 Carleton Street, Saint John, New Brunswick, in the Parish of Saint John, County of Saint John, and Province of New Brunswick, also known as PID 38133. Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of the first mortgage. Sale on the 19th day of February, 2015, at 11:30 a.m., at the Saint John County Registry Office at 2nd Floor, 15 King Square North, Saint John, New Brunswick. The Mortgagee reserves the right to postpone or reschedule the time and date of sale. See advertisement in the Telegraph-Journal. Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulaire de la première hypothèque. La vente aura lieu le 19 février 2015, à 11 h 30, au bureau de l’enregistrement du comté de Saint John situé au 15, King Square Nord, 2e étage, Saint John (Nouveau-Brunswick). La créancière hypothécaire se réserve le droit de reporter la date et l’heure de la vente. Voir l’annonce publiée dans le TelegraphJournal. Cox & Palmer, Solicitors for the Mortgagee, the Royal Bank of Canada Cox & Palmer, avocats de la créancière hypothécaire, la Banque Royale du Canada ________________ ________________ The Royal Gazette — January 21, 2015 88 Gazette royale — 21 janvier 2015 609508 NB INC., of 270 Orleans Street, Dieppe, New Brunswick, E1A 5E2, Mortgagor; JOSEPH MICHEL WILLIAM COMEAU, of 270 Orleans Street, Dieppe, New Brunswick, E1A 5E2, Guarantor; TRESCO HOLDINGS INC., Mortgagee and present holder of the First Mortgage; and to all others to whom it in any way may concern. Notice of Sale given by TRESCO HOLDINGS INC., the Mortgagee and present holder of the First Mortgage. Freehold lands situate at 53 Water Street, Campbellton, Parish of Addington, County of Restigouche and Province of New Brunswick. Sale on Monday, the 16th day of February, A.D., 2015, at the hour of 11:00 o’clock in the forenoon, at or near the main entrance to the County Court House, located at the City Centre Mall, Suite 202, 157 Water Street, P.O. Box 5001, Campbellton, in the County of Restigouche, and Province of New Brunswick. SEE ADVERTISEMENT IN THE TRIBUNE. 609508 NB INC., du 270, rue Orléans, Dieppe (NouveauBrunswick), E1A 5E2, débitrice hypothécaire; JOSEPH MICHEL WILLIAM COMEAU, du 270, rue Orléans, Dieppe (Nouveau-Brunswick), E1A 5E2, garant; TRESCO HOLDINGS INC., créancière hypothécaire et titulaire actuelle de la première hypothèque; et tout autre intéressé éventuel. Avis de vente donné par TRESCO HOLDINGS INC., créancière hypothécaire et titulaire actuelle de la première hypothèque. Terrains en tenure libre situés au 53, rue Water, à Campbellton, paroisse d’Addington, comté de Restigouche, province du Nouveau-Brunswick. La vente aura lieu le lundi 16 février 2015, à 11 h, dans l’entrée principale du palais de justice du comté, ou tout près, situé au Mall Centre-Ville, 157, rue Water, bureau 202, C.P. 5001, Campbellton, comté de Restigouche, province du Nouveau-Brunswick. VOIR L’ANNONCE PUBLIÉE DANS THE TRIBUNE. CYRIL C. SUTHERLAND, SOLICITOR FOR THE FIRST MORTGAGEE: TRESCO HOLDINGS INC. CYRIL C. SUTHERLAND, AVOCAT DE LA PREMIÈRE CRÉANCIÈRE HYPOTHÉCAIRE, TRESCO HOLDINGS INC. ________________ ________________ PROVINCE OF NEW BRUNSWICK COUNTY OF CHARLOTTE PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK COMTÉ DE CHARLOTTE NOTICE OF SALE TO: CLARENCE EDWARD GIBSON & DEBORAH ANN GIBSON, Owners of the Equity of Redemption and Original Mortgagors; GARY GIBSON, Guarantor; BHM FINANCIAL GROUP, Judgment Creditor; and to all others whom it may concern. NOTICE IS HEREBY GIVEN under and by virtue of the provisions of the Property Act, being Chapter P-19, R.S.N.B., 1973 and amendments thereto and by virtue of the provisions contained in a certain Indenture of Mortgage bearing date the 17th day of January, 2012 and registered in the Charlotte County Land Titles Office on the 18th day of January, 2012 as Number 31071567 and made between CLARENCE EDWARD GIBSON & DEBORAH ANN GIBSON, as Mortgagor and GARY GIBSON, as Guarantor and WILLOWRICH INVESTMENT FUND, as Mortgagee, there will, for the purpose of obtaining payment of monies secured by the said Indenture of Mortgage, default having been made in the payment thereof, be sold at public auction at Service New Brunswick, 93 Milltown Boulevard, St. Stephen, New Brunswick, on 10th day of February, 2015, at the hour of eleven o’clock (11:00 a.m.) in the forenoon, local time: PID #15060221 – being property located at 132 Route 725, Little Ridge, New Brunswick and 134 Route 725, Little Ridge, New Brunswick TOGETHER WITH all buildings and improvements thereon and the rights, privileges and appurtenances to the same belonging. AND FURTHER TAKE NOTICE that if a sufficient offer of purchase is not received for the said lands and premise at such public auction, the same may be withdrawn from such sale and disposed of by private contract without further notice being given. AVIS DE VENTE DESTINATAIRES : CLARENCE EDWARD GIBSON ET DEBORAH ANN GIBSON, propriétaires du droit de rachat et débiteurs hypothécaires; GARY GIBSON, garant; BHM FINANCIAL GROUP, créancier sur jugement; et tout autre intéressé éventuel. AVIS est par les présentes donné conformément aux dispositions de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19, et en vertu des dispositions contenues dans l’acte d’hypothèque établi le 17 janvier 2012 et enregistré au bureau de l’enregistrement foncier du comté de Charlotte le 18 janvier 2012, sous le numéro 31071567, entre CLARENCE EDWARD GIBSON ET DEBORAH ANN GIBSON, débiteurs hypothécaires, et GARY GIBSON, garant, et WILLOWRICH INVESTMENT FUND, créancière hypothécaire, que seront vendus aux enchères publiques en vue d’acquitter les sommes garanties par ledit acte d’hypothèque, étant donné le défaut d’en effectuer le paiement, à Services Nouveau-Brunswick, 93, boulevard Milltown, St. Stephen (Nouveau-Brunswick), le 10 février 2015, à 11 h, heure locale : le NID 15060221, correspondant aux biens situés au 132, route 725, Little Ridge (Nouveau-Brunswick) et au 134, route 725, Little Ridge (Nouveau-Brunswick) AINSI QUE tous les bâtiments qui s’y trouvent et les améliorations qui y ont été apportées, ainsi que les droits, les privilèges et les dépendances qui s’y rattachent. SACHEZ AUSSI qu’à défaut de recevoir une offre d’achat suffisante pour lesdits terrains et bâtiments dans le cadre de la vente aux enchères publique, ceux-ci pourraient être retirés de la vente et vendus par contrat privé sans autre avis. The Royal Gazette — January 21, 2015 89 Gazette royale — 21 janvier 2015 DATED at Woodstock, New Brunswick, this 7th day of January, 2015. FAIT à Woodstock, au Nouveau-Brunswick, le 7 janvier 2015. WILLOWRICH INVESTMENT FUND WILLOWRICH INVESTMENT FUND PETER A. BREWER, Solicitor for Willowrich Investment Fund, Brewer Law Offices, 4-113 Broadway, Woodstock, NB E7M 6B4, 506-325-2220 PETER A. BREWER, avocat de Willowrich Investment Fund, Brewer Law Offices, 4-113, rue Broadway, Woodstock (Nouveau-Brunswick) E7M 6B4, 506-325-2220 ________________ ________________ Sale of Lands Publication Act R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2) To: Line Anne Gallant Hebert and Claude Hebert, original Mortgagors; and to all others whom it may concern. Sale pursuant to terms of the Mortgage and the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts in amendment thereof. Freehold property being situated at 896 Walden Street, Miramichi, New Brunswick, the same lot conveyed to Line Anne Gallant Hebert and Claude Hebert by Transfer registered in the Land Titles System on May 4, 2012, as document number 31427835. Notice of Sale given by Bank of Nova Scotia as Mortgagee. Sale to be held at or near the front of the Court House for the Judicial District of Miramichi, 673 King George Highway, Miramichi, New Brunswick on the 13th day of February, 2015, at the hour of 11:00 a.m., local time. See advertisement of Notice of Sale in the Miramichi Leader dated January 14, January 21, January 28 and February 4, 2015. Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces L.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2) Destinataires : Line Anne Gallant Hebert et Claude Hebert, débiteurs hypothécaires originaires; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenure libre situés au 896, rue Walden, à Miramichi (Nouveau-Brunswick), correspondant au même lot ayant été transféré à Line Anne Gallant Hebert et Claude Hebert par l’acte de transfert enregistré dans le système d’enregistrement foncier le 4 mai 2012, sous le numéro 31427835. Avis de vente donné par la Banque de Nouvelle-Écosse, créancière hypothécaire. La vente aura lieu le 13 février 2015, à 11 h, heure locale, devant le palais de justice de la circonscription judiciaire de Miramichi, ou tout près, 673, route King George, Miramichi (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des 14, 21 et 28 janvier et du 4 février 2015 du Miramichi Leader. McInnes Cooper, Solicitors for Bank of Nova Scotia, Per: Adel Gönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400, P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6, Telephone: 506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095 Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Banque de Nouvelle-Écosse, Centre de la Croix Bleue, bureau S400, 644, rue Main, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6; téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095 ________________ ________________ TO: SHERRY DAWN SPENCER and THE ESTATE OF VINCENT RUSSELL SPENCER, Mortgagors; DESTINATAIRES : SHERRY DAWN SPENCER et LA SUCCESSION DE VINCENT RUSSELL SPENCER, débiteurs hypothécaires; ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL. Vente effectuée en vertu des dispositions du premier acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19, art.44. Biens en tenure libre situés au 42, rue Labelle, à Moncton, comté de Westmorland, province du NouveauBrunswick, et dont le numéro d’identification parcellaire est 70387360. Avis de vente donné par SERVICES DE FINANCEMENT TD RÉSIDENTIEL INC. La vente aura lieu le jeudi 12 février 2015, à 11 h 15, à l’hôtel de ville de Moncton, 655, rue Main, Moncton (NouveauBrunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des 14, 21 et 28 janvier et du 4 février 2015 du Times & Transcript. AND TO: ALL OTHERS TO WHOM IT MAY CONCERN. Sale conducted under the terms of the first mortgage under the Property Act, R.S.N.B., 1973, c.P-19, s.44 as amended. Freehold property situate at 42 Labelle Street, Moncton, Westmorland County, Province of New Brunswick and known as Parcel Identifier Number 70387360. Notice of Sale is given by TD FINANCING SERVICES HOME INC. The sale is scheduled for Thursday, February 12, 2015, at 11:15 a.m., at the Moncton City Hall, 655 Main Street, Moncton, New Brunswick. See advertisements in the Times & Transcript in the issues of January 14, January 21, January 28, and February 4, 2015. TD FINANCING SERVICES HOME INC., By: LAWSON CREAMER, Per: Veronica L. Ford, Solicitors for the TD Financing Services Home Inc. Veronica L. Ford, du cabinet LAWSON CREAMER, avocats de Services de financement TD résidentiel Inc. ________________ ________________ The Royal Gazette — January 21, 2015 TO: MARIE JEANNE DUPLESSIS, also known as JEANNE M. DUPLESSIS, and MOISE DUPLESSIS, Mortgagors; AND TO: ALL OTHERS TO WHOM IT MAY CONCERN. Sale conducted under the terms of the first mortgage under the Property Act, R.S.N.B., 1973, c.P-19, s.44 as amended. Freehold property situate at 234 Weisner Road, LakevilleWestmorland, Westmorland County, Province of New Brunswick and known as Parcel Identifier Number 70202528. Notice of Sale is given by TD FINANCING SERVICES HOME INC. The sale is scheduled for Thursday, February 12, 2015, at 11:00 a.m., at the Moncton City Hall, 655 Main Street, Moncton, New Brunswick. See advertisements in the Times & Transcript in the issues of January 14, January 21, January 28, and February 4, 2015. 90 Gazette royale — 21 janvier 2015 DESTINATAIRES : MARIE JEANNE DUPLESSIS, également connue sous le nom de JEANNE M. DUPLESSIS et MOISE DUPLESSIS, débiteurs hypothécaires; ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL. Vente effectuée en vertu des dispositions du premier acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19, art.44. Biens en tenure libre situés au 234, chemin Weisner, à Lakeville, comté de Westmorland, province du Nouveau-Brunswick, et dont le numéro d’identification parcellaire est 70202528. Avis de vente donné par SERVICES DE FINANCEMENT TD RÉSIDENTIEL INC. La vente aura lieu le jeudi 12 février 2015, à 11 h, à l’hôtel de ville de Moncton, 655, rue Main, Moncton (NouveauBrunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des 14, 21 et 28 janvier et du 4 février 2015 du Times & Transcript. TD FINANCING SERVICES HOME INC., By: LAWSON CREAMER, Per: Veronica L. Ford, Solicitors for the TD Financing Services Home Inc. Veronica L. Ford, du cabinet LAWSON CREAMER, avocats de Services de financement TD résidentiel inc. ________________ ________________ Sale of Lands Publication Act R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2) To: Chantale Lorraine Humble and Dale Charles Humble, original Mortgagors; and to all others whom it may concern. Sale pursuant to terms of the Mortgage and the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts in amendment thereof. Freehold property being situated at 181 Graveyard Hill, Stanley, New Brunswick, the same lot conveyed to Chantale Lorraine Humble and Dale Charles Humble by Transfer registered in the Land Titles System on March 28, 2008, as document number 25348336. Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces L.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2) Destinataires : Chantale Lorraine Humble et Dale Charles Humble, débiteurs hypothécaires; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenure libre situés au 181, Graveyard Hill, à Stanley (Nouveau-Brunswick), et correspondant au même lot ayant été transféré à Chantale Lorraine Humble et Dale Charles Humble par l’acte de transfert enregistré dans le système d’enregistrement foncier le 28 mars 2008, sous le numéro 25348336. Avis de vente donné par la Société hypothécaire Scotia, créancière hypothécaire. La vente aura lieu le 12 février 2015, à 11 h, heure locale, au palais de justice de Fredericton, 427, rue Queen, Fredericton (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des 14, 21 et 28 janvier et du 4 février 2015 du Daily Gleaner. Notice of Sale given by Scotia Mortgage Corporation as Mortgagee. Sale to be held at the Fredericton Justice Building located at 427 Queen Street, Fredericton, New Brunswick on the 12th day of February, 2015, at the hour of 11:00 a.m., local time. See advertisement of Notice of Mortgage Sale in The Daily Gleaner dated January 14, January 21, January 28 and February 4, 2015. McInnes Cooper, Solicitors for Scotia Mortgage Corporation, Per: Adel Gönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400, P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6, Telephone: 506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095 Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Société hypothécaire Scotia, Centre de la Croix Bleue, bureau S400, 644, rue Main, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6; téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095 ________________ ________________ Sale of Lands Publication Act R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2) To: Timothy Ryan Turner, original Mortgagor; and to all others whom it may concern. Sale pursuant to terms of the Mortgage and the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts in amendment thereof. Freehold property being situated at 2395 Route 845, Bayswater, New Brunswick, the same lot conveyed to Timothy Ryan Turner by Transfer registered in the Land Titles System on April 3, 2006, as document number 21908984. Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces L.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2) Destinataire : Timothy Ryan Turner, débiteur hypothécaire originaire; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenure libre situés au 2395, route 845, à Bayswater (Nouveau-Brunswick), et correspondant au même lot ayant été transféré à Timothy Ryan Turner par l’acte de transfert enregistré dans le système d’enregistrement foncier le 3 avril 2006, sous le numéro 21908984. The Royal Gazette — January 21, 2015 91 Gazette royale — 21 janvier 2015 Notice of Sale given by HSBC Bank Canada as Mortgagee. Sale to be held at the Saint John Provincial Building located at 10 Peel Plaza, Saint John, New Brunswick on the 12th day of February, 2015, at the hour of 11:00 a.m., local time. See advertisement of Notice of Mortgage Sale in the Telegraph-Journal dated January 14, January 21, January 28 and February 4, 2015. Avis de vente donné par la Banque HSBC Canada, créancière hypothécaire. La vente aura lieu le 12 février 2015, à 11 h, heure locale, à l’édifice provincial de Saint John, situé au 10, place Peel, Saint John (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des 14, 21 et 28 janvier et du 4 février 2015 du Telegraph-Journal. McInnes Cooper, Solicitors for HSBC Bank Canada, Per: Tony S. Richardson, Barker House, Suite 600, 570 Queen Street, P.O. Box 610, Station A, Fredericton, New Brunswick, E3B 5A6, Telephone: 506-458-8572, Facsimile: 506-458-9903 Tony S. Richardson, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Banque HSBC Canada, Barker House, bureau 600, 570, rue Queen, C.P. 610, succursale A, Fredericton (NouveauBrunswick) E3B 5A6; téléphone : 506-458-8572; télécopieur : 506-458-9903 Notice to Advertisers Avis aux annonceurs The Royal Gazette is published every Wednesday under the authority of the Queen’s Printer Act. Documents must be received by the Royal Gazette Coordinator, Legislative Services, no later than noon, at least seven days prior to Wednesday’s publication. Each document must be separate from the covering letter. Signatures on documents must be immediately followed by the printed name. The Royal Gazette Coordinator may refuse to publish a document if any part of it is illegible, and may delay publication of any document for administrative reasons. Prepayment is required for the publication of all documents. Standard documents have the following set fees: La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformément à la Loi sur l’Imprimeur de la Reine. Les documents à publier doivent parvenir à la coordonnatrice de la Gazette royale, aux Services législatifs, à midi, au moins sept jours avant le mercredi de publication. Chaque avis doit être séparé de la lettre d’envoi. Les noms des signataires doivent suivre immédiatement la signature. La coordonnatrice de la Gazette royale peut refuser de publier un avis dont une partie est illisible et retarder la publication d’un avis pour des raisons administratives. Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis. Voici les tarifs pour les avis courants : Notices Notice of the intention to apply for the enactment of a private bill Originating process Order of a court Notice under the Absconding Debtors Act Notice under the General Rules under the Law Society Act, 1996, of disbarment or suspension or of application for reinstatement or readmission Cost per Insertion $ 20 $ $ $ $ 25 25 20 20 Notice of examination under the Licensed Practical Nurses Act Notice under the Motor Carrier Act Any document under the Political Process Financing Act $ 25 Notice to creditors under New Brunswick Regulation 84-9 under the Probate Court Act $ 20 Notice under Rule 70 of the Rules of Court $120 $ 30 $ 20 Coût par parution Avis Avis d’intention de demander l’adoption d’un projet de loi d’intérêt privé Acte introductif d’instance Ordonnance rendue par une cour Avis exigé par la Loi sur les débiteurs en fuite Avis de radiation ou de suspension ou de demande de réintégration ou de réadmission, exigé par les Règles générales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur le Barreau Avis d’examen exigé par la Loi sur les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés Avis exigé par la Loi sur les transports routiers Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur le financement de l’activité politique Avis aux créanciers exigé par le Règlement du NouveauBrunswick 84-9 établi en vertu de la Loi sur la Cour des successions Avis exigé par la Règle 70 des Règles de procédure 20 $ 25 $ 25 $ 20 $ 20 $ 25 $ 30 $ 20 $ 20 $ 120 $ Nota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 po sur 14 po Note: Survey Maps cannot exceed 8.5″ x 14″ Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is 1/2 page in length or less $ 20 Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is greater than 1/2 page in length $ 75 Any document under the Winding-up and Restructuring Act (Canada) $ 20 Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces, si l’avis est d’une demi-page ou moins en longueur Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces, si l’avis est de plus d’une demi-page en longueur Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) 20 $ 75 $ 20 $ The Royal Gazette — January 21, 2015 92 Gazette royale — 21 janvier 2015 Notice of a correction charge is the same as for publishing the original document Avis d’une correction Any other document $3.50 for each cm or less Tout autre document les frais sont les mêmes que ceux imposés pour la publication du document original 3,50 $ pour chaque cm ou moins Payments can be made by cash, MasterCard, VISA, cheque or money order (payable to the Minister of Finance). No refunds will be issued for cancellations. Les paiements peuvent être faits en espèces, par carte de crédit MasterCard ou VISA, ou par chèque ou mandat (à l’ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation. The official version of The Royal Gazette is available free on-line each Wednesday. This free on-line service replaces the printed annual subscription service. The Royal Gazette can be accessed on-line at: La version officielle de la Gazette royale est disponible gratuitement et en ligne chaque mercredi. Ce service gratuit en ligne remplace le service d’abonnement annuel. Vous trouverez la Gazette royale à l’adresse suivante : http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ attorney_general/royal_gazette.html http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/ procureur_general/gazette_royale.html Print-on-demand copies of The Royal Gazette are available, at the following address, at $4.00 per copy plus 5% tax, plus shipping and handling where applicable. Nous offrons, sur demande, des exemplaires de la Gazette royale, à l’adresse suivante, pour la somme de 4 $ l’exemplaire, plus la taxe de 5 %, ainsi que les frais applicables de port et de manutention. Legislative Services Office of the Attorney General Chancery Place 675 King Street P.O. Box 6000 Fredericton, NB E3B 5H1 Services législatifs Cabinet du procureur général Place Chancery 675, rue King C.P. 6000 Fredericton (N.-B.) E3B 5H1 Tel: 506-453-8372 E-mail: gazette@gnb.ca Tél. : 506-453-8372 Courriel : gazette@gnb.ca Note: Deliveries are to be addressed to The Royal Gazette and left with the Commissionaire. Note : Toute livraison étant adressée à la Gazette royale doit être remise au commissionnaire. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved / Tous droits réservés
Source Exif Data:
File Type : PDF File Type Extension : pdf MIME Type : application/pdf PDF Version : 1.5 Linearized : No Author : giselel Create Date : 2015:01:14 15:32:32-04:00 Modify Date : 2015:01:14 15:37:20-04:00 XMP Toolkit : Adobe XMP Core 5.2-c001 63.139439, 2010/09/27-13:37:26 Creator Tool : PScript5.dll Version 5.2.2 Metadata Date : 2015:01:14 15:37:20-04:00 Format : application/pdf Title : The Royal Gazette / Gazette royale (15/01/21) Creator : giselel Producer : Acrobat Distiller 10.0.0 (Windows) Document ID : uuid:043ceb59-e89d-4035-92b8-8fd4fe5bc684 Instance ID : uuid:71fb859b-7318-454e-8a54-8fc3d2a3b868 Page Count : 32 Warning : [Minor] Ignored duplicate Info dictionaryEXIF Metadata provided by EXIF.tools