The Royal Gazette / Royale (15/01/21) 504241 Rg20150121

User Manual: 504241

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 32

The Royal
Gazette
Fredericton
New Brunswick
Gazette
royale
Fredericton
Nouveau-Brunswick
Vol. 173 Wednesday, January 21, 2015 / Le mercredi 21 janvier 2015 61
ISSN 1714-9428
Notice to Readers
The Royal Gazette is officially published on-line.
Except for formatting, documents are published in The
Royal Gazette as submitted.
Material submitted for publication must be received by
the Royal Gazette Coordinator no later than noon, at least
seven working days prior to Wednesday’s publication.
However, when there is a public holiday, please contact
the Royal Gazette Coordinator
at 453-8372
.
Elections
New Brunswick
Avis aux lecteurs
La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne.
Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dans
la Gazette royale tels que soumis.
Les documents à publier doivent parvenir à la coordon-
natrice de la Gazette royale, à midi, au moins sept jours
ouvrables avant le mercredi de publication. En cas de jour
férié, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de la
Gazette royale
au 453-8372
.
Élections
Nouveau-Brunswick
30 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF SAINT JOHN EAST (District No. 30) / ASSOCIATION DU PARTI
LIBÉRAL DE SAINT JOHN-EST (Circonscription no 30)
Official Agent / Agent officiel Tom Davidson
9, rue Alpine Street
Saint John, NB E2J 2X3
The Royal Gazette — January 21, 2015 62 Gazette royale — 21 janvier 2015
001900 001900 N.B. Inc.
051342 051342 N.B. LTD.
051521 051521 N.B. LTD.
051526 051526 N.B. LTD.
051532 051532 N.B. LTD.
056499 056499 N.B. LTD.
058783 058783 N.B. LTD.
059301 059301 N.B. LTD.
059435 059435 N.B. LTD.
636431 3409 RUE PRINCIPALE INC.
504197 504197 N.B. LTD.
506451 506451 N.B. LTD.
511146 511146 N.B. Ltd.
511244 511244 N.B. Inc.
511318 511318 N.B. LTD.
511319 511319 N.B. Ltd.
515980 515980 N.B. Ltd.
516071 516071 N.B. Ltd
516195 516195 N.B. Ltd.
605106 605106 N.B. INC.
605251 605251 N.B. LTD.
605424 605424 N.-B. Ltée
605444 605444 N.B. INC.
611144 611144 NOUVEAU-BRUNSWICK
CORPORATION 611144 NEW
BRUNSWICK CORPORATION
616950 616950 N.B. Ltd.
617127 617127 N.B. LTD.
617156 617156 NB Ltée 617156 NB Ltd.
617255 617255 N.B. Ltd.
617330 617330 NB Ltd.
617335 617335 N.B. Inc.
623573 623573 New Brunswick Ltd.
623644 623644 NB Inc.
623672 623672 NB Ltd.
623694 623694 NB LTEE
623707 623707 NB Ltd.
624052 624052 N.B. Inc.
624063 624063 N.B. Inc.
630036 630036 N.B. Ltd.
630068 630068 NB LTD.
630336 630336 N.B. INC.
636476 636476 N.B. Ltd. / 636476 NB Ltee
636498 636498 NB LTD.
636682 636682 NB INC.
636791 636791 N.B. Ltd.
636798 636798 N.B. Ltd.
636823 636823 N.-B. INC.
643047 643047 N.B. Inc.
643175 643175 N.-B. Inc.
649120 649120 NB INC.
649469 649469 NB Inc.
649493 649493 N.B. Ltd.
655621 655621 N.B. LTD.
655680 655680 N.B. Ltd.
655684 655684 NB LTD.
655752 655752 N.B. Ltd.
655838 655838 NB Inc.
655868 655868 N.B. LTD.
655901 655901 NB INC.
655904 655904 NB Inc.
661958 661958 N.B. Ltd.
661974 661974 N.B. Inc.
662015 662015 N.B. Ltd.
662041 662041 NB Inc.
662080 662080 N.B. LTD.
662081 662081 N.B. INC.
662082 662082 Nouveau-Brunswick Inc.
662179 662179 NB Inc.
662205 662205 N.B. Inc.
662267 662267 N.-B. INC.
662285 662285 NB INC.
662287 662287 N.B. INC.
662364 662364 N.B. Ltd.
662375 662375 N.B. Inc.
662391 662391 N.B. Ltd.
662400 662400 NB Inc.
662413 662413 N.B. Inc.
668242 668242 NB LTD.
668291 668291 NB Inc.
668334 668334 N.B. Inc.
668607 668607 N.B. Ltd.
668744 668744 N.-B. Ltée
668756 668756 N.B. Inc.
668831 668831 NB INC.
668856 668856 NB LTD.
668916 668916 NB Ltd.
051529 A & J CONSTRUCTION LTD.
662083 A & M Rentals Ltd.
642738 A. BERTIN & FILS LTÉE - A BERTIN &
SON LTD.
008760 A. G. JEAN LTEE.
610884 ABC Adventures Ltd.
668261 Adica Group Inc.
655763 AEG Innovation & Design Inc.
668720 AIRLOK INSULATION LTD.
624028 AJM HOLDINGS INC.
501582 ALDOUANE AQUACULTURE LTEE.
649137 Alma Park Store Ltd.
662264 ALTROLS CONTRACTING INC.
000647 APPLEWOOD ACRES LTD.
643184 Arctic Light Construction Ltd.
611036 ARSENICK CORPORATION
605478 ATCON PROPERTY HOLDINGS INC.
605236 ATCON STRUCTURES INC.
662118 Atlantic College of Information
Technology / Collège des Technologies
de l’Information de l’Atlantique Inc.
649092 Avonmark Capital Limited
617126 Balticum Business Group Ltd.
605384 BARTHOLOMEW RIVER
DEVELOPMENT LTD.
662050 BASALTIC SOLUTIONS INC.
053516 BEJEWEL BY TRUDY GALLAGHER
LTD.
617089 BELLEISLE GARDENS
GREENHOUSE NURSERY INC.
636412 BERNCOR HOLDINGS LTD.
514012 BH STATION SERVICE LTEE
668843 Blue Sky Properties Ltd.
668646 Bob & Ron’s Transportation Ltd.
043954 BOBA HOLDINGS INC.
636896 Boom Crane Rental Services Limited
623604 Boucher Sales Ltd.
642781 Boum Distribution and Marketing Inc.
623632 Brantville Acquaculture Ltee.
033260 BRASETTE LA CHALOUPE LTEE
059454 BREAK 4 LOGGING LTD.
649312 Brew-Tec Concrete Ltd.
649232 Bruce Brown Construction and
Renovation Ltd.
605454 BRUNSWICK PLUMBING SERVICES
LTD.
656032 Burgess Freight Carriers Inc.
002678 C & K ENTERPRISES LTD.
002747 CABOT LUMBER LTD.
611158 Caledonia Collision Center Inc.
056716 CAMCO CONSTRUCTION LTD.
642667 Capital Airways Inc.
003127 CAROL HOLDINGS LTD.
668617 CAS Roofing & Siding Ltd.
046241 CASEY SPRING LUMBER LTD.
048737 CHALEUR AUTO SERVICE LTD./
LTEE
610802 Chester Holdings Ltd.
508759 Classic Comfort Company Ltd.
053609 COCAGNE EXCAVATING LTD.
668822 Cold Fall Corporation
516190 CONCEPT PED HOLDING INC.
636430 Corporation professionnelle Dre Adama-
Rabi Youla MD Inc.
046708 CROWN FENCE SUPPLY LTD.
668299 Cut-er-All Concrete Sawing and Drilling
Ltd.
616946 D & R Custom Cedar Inc.
031618 D. & M. CRANE RENTAL LTD.
041291 D.E.M. HOLDINGS INC.
662401 DAKIN’S CONTRACTING LTD.
056671 DALEY FAMILY HOLDINGS LTD.
501852 DALY INVESTMENTS LTD.
636429 DAN DOUCET CONSULTANT INC.
662232 Daniel Castonguay Holdings Inc.
668091 Davenport Trucking Inc.
630470 DAVID & ABRAHAM INC.
668627 David H. Dunsmuir (2013) Professional
Corporation
636635 Deke’s Enterprises Ltd.
004891 DELUXE FISH & CHIPS LTD. -
DELUXE FISH & CHIPS LTEE
648693 Dépanneur Guitard Inc.
Avis d’une décision de dissoudre les corporations provinciales
et d’annuler l’enregistrement des corporations extraprovin-
ciales
Avis d’une décision de dissoudre les corporations provinciales
Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations
commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations sui-
vantes en vertu de l’alinéa 139(1)c) de la Loi, puisque lesdites corpo-
rations ont fait défaut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/
ou documents requis par la Loi. Soyez avisé que 60 jours après la date
de la publication du présent avis dans la Gazette royale, le Directeur
pourra dissoudre lesdites corporations.
Loi sur les corporations
commerciales
Notice of a decision to dissolve provincial corporations and to
cancel the registration of extra-provincial corporations
Notice of decision to dissolve provincial corporations
Take notice that the Director under the Business Corporations Act has
made a decision to dissolve the following corporations pursuant to
paragraph 139(1)(c) of the Act, as the said corporations have been in
default in sending to the Director fees, notices, and/or documents re-
quired by the Act. Please note that 60 days after the date of publication
of this Notice in The Royal Gazette, the Director may dissolve the
corporations.
Business Corporations Act
The Royal Gazette — January 21, 2015 63 Gazette royale — 21 janvier 2015
513964 Dépanneur Léger Inc.
038934 DES’S FURNITURE REFINISHING
(1987) LTD.
636750 DESIGN 4 SPACE INC.
623831 Double Diamond Management Ltd.
044015 DOUG CHASE ENTERPRISES LTD.
668919 DOWNFORCE AUTOWORKS INC.
617360 Dr Frédéric Goguen c.p. Inc.
605210 DR. DENISE DUGUAY-VIBERT
CORPORATION
PROFESSIONNELLE INC.
655683 Dr. Matthieu Gaudet Corporation
Professionnelle Inc.
668608 Dr. Oludara-Fadare P.C. Inc.
508849 Dr. Peter Feero P.C. Inc.
649198 Dr. S.M.P. Tran Professional Corporation
051469 DR. T. TOUDJIAN PROFESSIONAL
CORPORATION
516205 Dre MÉLANIE CHAREST C.P. INC.
668243 Dre Micheline Boucher-Robichaud C.P.
Inc.
514025 Dream Kitchen Plus Ltd.
649581 DROST CONSTRUCTION INC.
041305 E. F. CHRISTIE & SONS INC.
516300 Eastern Canadian Maple Products Inc./
Produits d’Erable de l’Est canadien Inc.
605455 EastServe GroundsCare Inc.
655731 EDWARD DOIRON CONSULTING
LTD.
041389 EFFECTIVE PARTICLE
TECHNOLOGIES LTD.
649434 Egg Films NB Inc.
617376 ELEMENTAL CODEWORKS INC.
668681 ELLE EST BELLE SERVICES CORP.
636745 Embracor Ltd.
623553 EMC Executive Management Consulting
Inc.
656091 ENCORE ATM-POS INC./ENCORE
GAB-TPV INC.
655632 Enigma Movie and Scripts Corporation
668695 ENTER RENOVATIONS INC.
630447 ENTREPRISES J.V.L. INC.
030082 ENTREPRISES MALLET LIMITEE
630438 ESQU CERTIFIED LTD.
636759 F & G EURO FLOORING LTD.
662280 Faithful Servant Books Inc.
059494 FERME ARMAND GODBOUT LTEE
656092 Ferme J & D.L. Farms Inc.
605394 FISH-ON-BAIT COMPANY, CANADA
LTD.
649259 FourJ Steel Incorporated
662099 Franzen Canada Corp.
649531 FRESH FROM THE SEA LTD.
504231 FROSTY HOLLOW SYLVACULTURE
& LOGGING INC.
668913 FUNDY LASERFAB LTD.
511192 G.A. DUNCAN ELECTRIC LTD.
655770 GERT’S PLACE INC.
053525 GESTION B & M MICHAUD LTEE
007089 GESTION MOCO LIMITEE
501725 GESTION R. CYR MANAGEMENT
INC.
504171 GLENCO HYDROSPRAYER LTD.
053610 GLOBAL MECHANICAL SYSTEMS
LTD.
501732 GOLD COAST MARINE
CONSULTANT INC.
059440 GOLDEN SISTERS LIMITED
053399 GOULD’S FRIED CLAMS LTD.
007503 GREEN’S RESTAURANT LIMITED
662274 GROUNDS EFFECTS LANDSCAPING
LTD.
034987 HAINES PHARMACY LTD.
668315 HDR Motorsports Ltd.
649464 Headway Rehabilitation Inc.
668325 hearingaidrental.ca Ltd.
642758 Hickory Holdings Ltd.
031531 HOLLAND FOOD IMPORTS LTD.
504241 HYDRA-FAB INDUSTRIAL INC.
516283 Ian J. Warren Ltd.
655940 IFJ West Holdings Ltd.
668781 IMEX Sourcing Inc.
668348 Immilease Inc.
041207 IMPRESSION PROMOTION LTD.
034901 INDIAN ISLAND VACATIONS INC.
623990 INDUSTRIAL HYDRO-VAC NB LTD.
636817 INSTITUT BEAUBASSIN INC.
052315 INSTITUT EDUKA INC.
668939 Intergrated Systems Consulting Inc.
617188 INVESTISSEMENTS DDH INC.
668895 Iron Wolf Mining Inc.
610893 J & J Cummings Housing Ltd.
649479 J. Cloutier Professional Corporation
504084 J.K.S.V. ENTERPRISES LTD.
059532 J.S. SHIPBUILDING CONSULTANTS
LTD.
056585 JAMES F. IZZARD PROFESSIONAL
CORPORATION
662380 Jamie Cummings Housing &
Development Ltd.
616869 JEMDAC INC.
656066 Jenta Engineered Solutions Ltd.
513951 JIM’S FAMILY CONVENIENCE
STORE LTD.
668592 Joel’s Pizza Inc.
504116 JOGE ENTREPRISE LTD
008462 JOHN L. INGERSOLL & SONS LTD.
049264 JOHN MCGUIRE SALES LTD.
616998 John Mick Inc.
662173 JVY TRANSPORT INC.
668905 K & L Electric Ltd.
649562 KA&LMD Holdings Inc.
668276 Kentin Forestry Inc.
655790 KHD - KustomHAUS Designs Inc.
649440 Knight North America Corp.
668342 KST Tech Group Inc.
649563 L&KAMD Investments Inc.
031534 LAITERIE MARTEL LTEE
642879 Landi Investments Inc.
642953 Le coin des pecheurs 2009 Inc.
649388 Le Restaurant Familial Jac-Pit Inc.
056335 LES ENTREPRISES HARRY FRYE
LTEE
516166 Les entreprises Lanwon Inc./Lanwon
Enterprises Inc.
642791 LET’S PLAY ENTERTAINMENT LTD.
668302 LinkState Technologies, Inc.
516251 Little Sneakers Daycare Inc.
649345 LOAAT CONSULTING (N.B.) INC.
668824 LONE TREE VENTURES INC.
516275 LONGING VENTURES INC.
030124 M. J. SCHMIDT & SON LTD.
010241 M. T. A. SALES LTD.
501710 M.C. TRIMMING & CUTTING TREE
LTD
617025 M.D. PELLERIN LUMBER INC.
511266 M.P. AQUACULTURE INC.
649280 M.R. Service Center Ltd.
051461 MACDOUGALLS FARM LTD.
516343 MacKELLAR CUNNINGHAM &
ASSOCIATES LTD.
605419 MacPherson Group Limited
010409 MAPLE GROVE TRAILER PARK LTD.
516276 Marco & Clarence Forestiere Ltee
010749 MATTHEWS BROS. LTD.
010768 MAYFAIR BEVERAGE ROOM (1979)
LTD.
011742 MCKINNEY MANAGEMENT
SERVICES LTD.
010823 MEL ENTERPRISES LTD.
010889 MERV’S CATERING RESTAURANT &
BAKERY LTD.
056521 Metlantech Inc.
513948 MILLIGAN’S CYCLE WORKS INC.
038874 MINTO FINE FURNITURE LTD
605267 Miramichi Career College Inc.
655708 mode de vie Carelle’s lifestyle Inc.
662342 MONEY CAFE INC.
011397 MORUE IMPERIALE LTEE
649333 MSL Carriers Ltd.
610888 MULTI-RECYCLING LTD.
668633 N.J.E. Enterprises Inc.
668341 North East Paper Inc.
655915 NRG Durable Inc./Durable NRG Inc.
668872 O.I. Holdings Inc.
668647 onVDO Corporation
506522 P & A TIMBER INC.
649208 Palmer Management Services Ltd.
656036 Panacea Body Wellness Centres (NB)
Limited
668864 PARA BEAUTY INC.
655704 Patient Television Services Inc.
511373 PATRICK L. MURCHISON
PROFESSIONAL CORPORATION
511092 PCS LabMentors LTD.
636920 PERPETUAL SECURITY
CORPORATION
662167 Pièces Parts Expert Inc.
013132 PINES ENTERPRISES LTD.
049213 PORCHERIE DU CENTRE V.T. INC
041390 POWER PLAY SPORTS & HOCKEY
CLINICS INC.
516238 PRATIQUE MEDICALE CORMIER &
OUELLETTE C.P. INC.
649154 Premium ESL Canada Inc.
504083 PRINCE EDWARD DEVELOPMENTS
LIMITED
649256 Profloor Installs Ltd.
605323 PRS Enterprises Ltd.
623574 R & S Mining Consultants Inc.
031434 R. LANDRY HOLDING LTD.
668701 R.W. Morton Construction Inc.
516191 RESIDENCE COMPLEXE
BONACCORD INC.
649067 RESTIGOUCHE AQUACULTURE
LTD.
649354 Restigouche Centre of Excellence in
Athletic Skill Development Inc.
506432 REYNOLDS RV SALES LTD.
056436 RICHARD SHEET METAL LTD.
056575 RITCHIE’S PLUMBING & HEATING
INC.
655642 River Bend Consulting Inc.
610911 RIVERSIDE COACH LINES INC.
623625 Riverview Comfort Inc.
034899 RIVERVIEW MUFFLER CENTER LTD.
513913 RMLE Location Ltée
642905 ROWCOR Technologies Inc
624015 S.A. ORR & SEARS LTD.
014502 SABRA LIMITED
643022 San Wen Feng Shui Planning Corporation
Inc.
623648 Savage’s Bicycle Centre Inc.
044000 SCOTT IRVING SHEET METAL LTD.
643001 SEA DREAM FISHERIES LTD.
014961 SECURITY PHOTO PROFILE LTD.
617366 SERGE H. BRIDEAU GARAGE &
SCRAP METALS LTD
662146 Serre APOLO Greenhouse Inc.
668860 SGN Construction Management Inc.
053464 SHAMROCK HOLDINGS LTD.
649285 Silver Daisy Designs Inc.
041224 SILVER HARVEST LTD.
668845 Smile a While Dairy Bar Inc.
668593 Snack & Bevy Shack Inc.
655742 Solstice Soap Co. Inc.
654456 Spa Chance Harbour inc.
015451 SPENCER TRUCKING LIMITED
668873 Stephen LeBlanc Financial & Investment
Services Ltd.
630251 Stewart & Stevenson Canada Inc.
043944 STIEF LTD.
636897 Sugar Island Foods Inc.
668591 SUITE SERENDIPITY LTD.
668308 Sunray Solar Inc.
630163 Sunrise Diner Ltd.
668680 Supreme Energy Centre Inc.
The Royal Gazette — January 21, 2015 64 Gazette royale — 21 janvier 2015
660458 Synergy Properties Inc.
649118 T & G Holdings Incorporated
617294 T.J. MAILLET RESIDENCES LTD.
655913 Taylor Lake Aggregates Inc.
668323 TECHVEDIC NEW BRUNSWICK INC.
053283 TEDISH HOLDING LTD.
668238 Telefoniks Digital Inc.
049197 TexMedico Inc.
508779 The Washburn Group Financial Advisors
Inc.
056515 TILLEY TAKE-OUT LTD.
662332 TJM ENTERPRISES INC.
623977 Tom Egers Excavating Ltd.
610775 Transport 04 Inc.
617300 Travacom Properties Inc.
016369 TRI-GIL PAVING & CONSTRUCTION
LTD
636793 Tritium Software Inc.
668786 TruGreen Landscaping Ltd.
016657 VALLEY DISTRIBUTORS LTD.
649568 Verge Point Construction Ltd.
643170 VICTORIA GROWERS LTD.
649127 Vista Ridge Homes Inc.
051421 VOLUME TRUCK & EQUIPMENT
SALES LTD.
016898 WALKER & ASSOCIATES LTD.
636828 Waveney Holdings Inc.
617187 WEST-WOOD MANUFACTURING
LTD.
662147 Wet to Dry Basement Solutions Inc.
030116 WINDOWS INTERNATIONAL SALES
& INSTALLATION LTD.
610966 XTRA PC INC.
617303 ZEAN’S AUTO REPAIR LTD.
668841 Zliv Creations Inc.
655809 2081109 ONTARIO INC.
636597 3089-2400 Québec Inc.
662144 8078637 Canada Inc.
662197 8100896 Canada Inc.
668752 8407690 Canada Inc.
623612 Advantage Communications Inc.
636785 AKVA group North America Inc.
668597 Alimentation L’épicier inc.
076635 ALLIED INTERNATIONAL CREDIT
CORP./SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
DE RECOUVREMENT ALLIED INC.
649048 ASSET APPRAISAL SERVICES
(CANADA) INC. SERVICE
D’ÉVALUATION D’ÉQUIPEMENTS
(CANADA) INC.
662126 Breakwater Resources Ltd.
649099 Centric Disability Management Inc.
636853 CLOVERCONCEPT INVESTMENTS
LTD.
073144 COMSTOCK CANADA LTD.
630088 Connor, Clark & Lunn Private Capital Ltd.
624030 DR CHARLES JOURNET P.C. INC.
668736 DTComposite Ltée
649065 Dynamic Tire Corp.
662115 Edulife Centre Eduvie Inc.
630047 Entreprises forestières sapins Verte inc
649590 Futurebright Insurance Group Inc./Groupe
Assurances Futurebright Inc.
073624 GOJIT INC.
630384 GROUPE MÉGA SERVICE INC.
668868 HOLLOWAY LODGING
CORPORATION
661810 IAM Building Systems Inc.
623968 IGRI INC.
630385 J. H. SAUVÉ ET FILS (1979) INC.
654367 KARRYS BROS., LIMITED
668163 Les Gestions Lecram Ltée.
655956 Les Systèmes Equinox Inc.
078090 MILLER INTERMODAL LOGISTICS
SERVICES, INC.
643051 NEXIM CANADA INC.
078062 Nortel Networks Technology
Corporation/Corporation Technologie
Nortel Networks
668255 PIONEER FUELS INC.
661998 Point Zero One Realty Limited
630300 QUADRA CHEMICALS LTD.
624044 QUANTUM MURRAY GP INC.
019661 SEAMARK ASSET MANAGEMENT
LTD.
668734 SHS SERVICES MANAGEMENT INC
GESTION DES SERVICES SHS INC.
629804 TD SERVICES PLUS INC.
662372 TECHNOLOGIES SYNERSTAR INC.
SYNERSTAR TECHNOLOGIES INC.
077560 W.T. RAWLEIGH CO.
662388 WEEKES GENERAL CONTRACTING
LTD.
668237 WINMAR FRANCHISE CORP.
649369 WJC MAINTENANCE SERVICES LTD.
643092 WOODY’S AUCTIONS LIMITED
022293 Association régionale de la communauté
francophone de Saint-Jean inc.
003081 CARLETON CURLING CLUB,
LIMITED.
024895 CARLETON MANOR FOUNDATION
INC.
003307 CENTRE COMMUNAUTAIRE
PAROISSE STE-CECILE SPORTS &
LOISIRS, INC.
021774 CODIAC VIKINGS AQUATIC CLUB
INCORPORATE CLUB AQUATIQUE
CODIAC VIKINGS INCORPOREE
025258 COMMISSION INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE DU GRAND
SHIPPAGAN INC.
004143 CONGREGATION SHAAREI-ZEDEK,
LIMITED
004182 CONSEIL RECREATIF DE STE.
MARIE INC.
____________________
Notice of decision
to cancel the registration of extra-provincial corporations
Take notice that the Director under the Business Corporations Act has
made a decision to cancel the registration of the following extra-
provincial corporations pursuant to paragraph 201(1)(a) of the Act, as
the said corporations have been in default in sending to the Director
fees, notices, and/or documents required by the Act. Please note that
60 days after the publication of this Notice in The Royal Gazette, the
Director may cancel the registration.
____________________
Avis d’une décision
d’annuler l’enregistrement des corporations extraprovinciales
Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations
commerciales, a pris la décision d’annuler l’enregistrement des corpo-
rations extraprovinciales suivantes en vertu de l’alinéa 201(1)a) de la
Loi, puisque lesdites corporations ont fait défaut de faire parvenir au
Directeur les droits, avis et/ou documents requis par la Loi. Soyez avisé
que 60 jours après la date de la publication du présent avis dans la
Gazette royale, le Directeur pourra annuler l’enregistrement desdites
corporations extraprovinciales.
Avis d’une décision de dissoudre les compagnies provinciales
Soyez avisé que le Directeur, en application de la Loi sur les compa-
gnies, a pris la décision de dissoudre les compagnies suivantes en vertu
de l’alinéa 35(1)c) de la Loi, puisque lesdites compagnies ont fait dé-
faut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou documents re-
quis par la Loi. Soyez avisé que 60 jours après la date de la publication
du présent avis dans la Gazette royale, le Directeur pourra dissoudre
lesdites compagnies.
Loi sur les compagnies
Notice of decision to dissolve provincial companies
Take notice that the Director under the Companies Act has made a de-
cision to dissolve the following companies pursuant to paragraph
35(1)(c) of the Act, as the said companies have been in default in send-
ing to the Director fees, notices, and/or documents required by the Act.
Please note that 60 days after the date of publication of this Notice in
The Royal Gazette, the Director may dissolve the companies.
Companies Act
The Royal Gazette — January 21, 2015 65 Gazette royale — 21 janvier 2015
630071 Curryville Community Outreach Center
Inc.
668909 D.D Net Works Inc.
022530 DEJA VU/SECOND HAND CLOTHING
STORE INC.
025229 DEVELOPMENTAL SERVICES
(SAINT JOHN) INC.
025687 EATING DISORDER COUNCIL OF
NEW BRUNSWICK INC.
006298 FLORENCEVILLE CURLING CLUB,
LTD.
668270 Friends of Cameroon Inc.
668637 Grappe en Composites NB Inc. - NB
Composites Cluster Group Inc.
024137 HILLSBOROUGH KIWANIS
COMMUNITY CENTER, INC.
008545 IRISHTOWN COMMUNITY CENTRE
INC.
025834 JUDO NB INC.
623725 JUSTICE & EQUITY Inc.
024560 KENNEBECASIS VALLEY HIGH
SCHOOL ACTIVITIES
COMMITTEE, INC.
024366 LAKEHEAD R.V. CLUB INC.
023321 LE MOUVEMENT SCOUTS ET
GUIDES DE DRUMMOND INC.
024332 LES POMPIERS DE SAINTE-ANNE DE
MADAWASKA INC.
662328 Lutte New Brunswick Wrestling Inc.
006783 Manufactured Housing Association of
Atlantic Canada Inc.
025840 Marathon by the Sea, Inc.
011544 MCADAM LIONS CLUB INC.
630099 Moncton Flyers Hockey Club Inc.
024361 MOUNTAINVIEW TRAILMAKERS
SNOWMOBILE CLUB INC.
024892 NASHWAAK WATERSHED
ASSOCIATION INC.
023605 PARTAGE & AMITIE INC.
605525 PETTY TRAIL BLAZERS ATV CLUB
INC.
668820 Renewed Hope Church of God Ltd.
667489 Réseau d’inclusion communautaire de
Kent/Kent Community Inclusion
Network Inc.
636835 ROCKINGSTONE GARDEN HOMES
INC.
023328 SAINT JOHN ASSOCIATION FOR
COMMUNITY LIVING, INC.
668721 ST. JAMES COMMUNITY
FOUNDATION INC.
021533 ST. MARY’S CEMETERY LTD. -
CIMETIERE STE MARIE LTEE
022080 STICKNEY & AREA RECREATION
COUNCIL INC.
023333 THE JOHN HOWARD SOCIETY OF
FREDERICTON, INC.
016190 TIFERES ISRAEL LTD.
647510 Alward Brothers Farm
609363 ANNCATH-ROBY CRAFTS
648462 ATLANTIC CONCIERGE SERVICE
647801 Canned Games
647817 Cargojet Regional Partnership
647655 COLOR GLO NEW BRUNSWICK
609496 DREAM COTTAGE
646602 Dream Fitness
647479 GAGNE ET CYR OPTOMETRISTES
648292 Gower Exteriors
348062 GRAHAM EXPORT SALES
647623 Green Acres Estate
609418 Kchikhusis Daycare
647803 Le Petite-Chapeau
603570 Les Moulures Lumar Mouldings
647332 Maritime Spray Foam
647525 SHERMTREV ENTERPRISES
345806 Spacek & Norrad Chartered Accountants
609550 Thornton Projects
647622 V-Sure Enterprises
647631 21st Century Resumes
646899 878 Waterfront Bistro & Café
615443 Acadie Trophy
615225 ACE OF TRADES CONTRACTING
647874 ADDICTION PSYCHIATRY AND
METHADONE CARE (MIRAMICHI)
REG’D.
609565 ADORABLE
608777 ADRIEN CHARPENTIER MENUISIER
609404 ADVANCED ADHESIVES
647786 ALBO’S BUILDING AND
RENOVAT IONS
648182 ALL IN ONE MUSIC
647936 ANGEL CITY TATTOOS
648277 Aqua Blast Hot Tubs Sales & Service
615705 Arthur Ross A M Trucking
342857 Association des Bibliothécaires et
Professeur.e.s Retraités de l’Université
de Moncton
648468 ASTRO C. D. TRUCKING
647693 At Your Finger Tips-Est.2009
646968 ATLANTIC AIR AMBULANCE
609636 Auberge Centre-Ville Enr.
647723 AUBERGE PITOU EN VACANCE
609519 AUDUBON ORGANICS
647759 B&J CARPENTRY & GARDENING
647834 B.W. Auto Cleaning Specialists
641616 Balanced Viewpoint
647710 Barry’s Discs
609300 BASKET SHOPPE QUALITY
GOURMET GIFTS
647658 Bay of Fundy Shark Fishing Charters
SACHEZ QUE, conformément aux articles 12.3 et 12.31 de la Loi sur
l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations com-
merciales, L.R.N.-B. de 1973, chap. P-5, le registraire a l’intention, en
vertu de ladite loi, d’annuler l’enregistrement des certificats de sociétés
en nom collectif indiquées à l’annexe « A » ci-jointe et des certificats
d’appellations commerciales des commerces indiqués à l’annexe « B »
ci-jointe, en raison du fait que ces firmes ou commerces ont négligé de
faire enregistrer des certificats de renouvellement conformément à
l’alinéa 3(1)b) ou c) ou au paragraphe 3.1(2) ou 9(7) de ladite loi, selon
le cas.
SACHEZ AUSSI qu’en tout temps après la date d’expiration de trente
(30) jours à partir de la date de publication du présent avis, le registraire
peut annuler l’enregistrement desdits certificats de sociétés en nom
collectif et certificats d’appellations commerciales.
Loi sur l’enregistrement des
sociétés en nom collectif et
des appellations commerciales
TAKE NOTICE that, pursuant to sections 12.3 and 12.31 of the Part-
nerships and Business Names Registration Act R.S.N.B., 1973, c. P-5,
the Registrar under the said Act intends to cancel the registration of the
certificates of partnership of the firms set forth in Schedule “A” an-
nexed hereto and the certificates of business names of the businesses
set forth in Schedule “B” annexed hereto by reason of the fact the said
firms and businesses have failed to register certificates of renewal in
accordance with paragraph 3(1)(b) or (c) or subsection 3.1(2) or 9(7),
as the case may be applicable, of the said Act.
FURTHER TAKE NOTICE that at any time after the expiration date of
thirty (30) days from the date of publication of this Notice, the Regis-
trar may cancel the registration of the said certificates of partnerships
and certificates of business names.
Partnerships and Business
Names Registration Act
Schedule “A” / Annexe « A »
Certificates of Partnerships / Certificats de sociétés en nom collectif
____________________________________________________
Schedule “B” / Annexe « B »
Certificates of Business names / Certificats d’appellations commerciales
The Royal Gazette — January 21, 2015 66 Gazette royale — 21 janvier 2015
648174 Berry’s Auto & Recreation
609380 Bertelsen Properties
648330 BEST ALARMS
647615 Beyond Bronz Tanning
648117 BGP Technologies
647947 Bolduc Forestry Services
647941 Boost Research & Development
647534 Bordertown Collision Centre
647897 Boudreaus Bay AutoBody
647752 BOUTIQUE 31
648298 Brian McCulloch’s Small Engine Repair
647636 Britta’s Bear Island Bed & Breakfast
647503 Bronzage D’Azur
647574 Buen Dia Canada
647924 C.B. DeMerchant & Sons
647257 CANACCORD ADAMS
647271 CANACCORD CAPITAL
647272 CANACCORD INSURANCE
SERVICES
647270 CANACCORD WEALTH
MANAGEMENT
648472 CANACCORD WEALTH
MANAGEMENT
647721 CANARGY FOODS
647626 Canuck Web Services
615488 Capital Spring and Suspension
310810 CARLETON-KIRK LODGE
332553 CARTIER WINES & BEVERAGES
647856 CBW Bookkeeping Services
647733 CENTRE AUDITIF BEAUSÉJOUR
HEARING CENTER
615634 Centre Dentaire Elmwood/Elmwood
Dental Centre
647504 Charlotte County P.M.S. Property
Management Services
647546 CITICORP HOME MORTGAGE
647547 CITICORP HYPOTHÈQUES
RÉSIDENTIELLES
647585 CLEAN VOLT ATLANTIC
647582 Clinique l’Endodontie de Grand-Sault/
Grand Falls Endodontics Clinic
647624 Clinique Myocare Clinic
648401 Cobalt Crow Productions
615650 Cogerno
646727 Coiffure Pra
647549 Coldwell Banker Dynamic Realty
615391 COLWELL SECURITY SYSTEMS
648098 Cool Cat Creations
615403 Corkum Photographics
615455 Country Studio
616358 Countrycatz
647666 Coverdale Renovations
337759 COX COMMUNICATIONS
648483 CRC CONSULTANTS &
RÉPARATIONS CLINIQUE / CRC
CLINICAL REPAIRS &
CONSULTANTS
647505 Creative Boss
609554 CREDIT CONSEIL PLUS DU N B
CREDIT CONSULTANTS PLUS
OF N B
335044 CURLN COMB
615727 D-micro Technology
610164 D. ELLIS AUTO SALES
615665 Danielle’s Lingerie
647506 DAVE’S REFINISHING SERVICES
647516 DAY & ROSS TRADE NETWORKS
647572 Depanneur & Station Service Harricana
615608 Dependable Auto Sales
647701 Dixon Plumbing & Heating
322081 DOBSON CHRYSLER DODGE
647772 DOCTEUR GUM DOCTOR
609391 DOOLY’S BLUE ROOM
647511 DOWN EAST MOBILE WASH
647099 Down the Lane Beauty Salon
647888 Dr. Dish, Satellite TV Specialist
647512 DT PIZZA
340679 DUPMAG CONSULTATION
647653 EAST COAST PEOPLE’S CHOICE
AWARDS
648427 Eastern Paint Ball Supplies
647792 Easy Travel
647876 ECO - ART UNLIMITED
647804 Eco Clean
648314 Elm Creek Livestock Equipment
647917 Empire Stevedoring (Maritimes) Co.
647760 Enseignes Maximum Signs
615384 EXPLORE YOUR WORLD DAYCARE
647955 EXTREME DRIVEWAY SEALER
647565 Eye Shine Studio
615801 FCPC
648143 Fire & Ice Graphix
615591 First Organic Bakery
646494 Fitness Excellence Athletic Training
(FEAT)
647603 Flight Graphics and Design
615800 FOOD AND CONSUMER PRODUCTS
OF CANADA
647903 FOREVER YOUNG SPECIAL CARE
615592 Fournier & Associés Enr.
647575 Fredericton Mitsubishi
314185 FREDERICTON REALTY
648220 FRESH GROUND CAFE
647643 FRONTIER DIVING
647621 Fruit Sendsations
647755 Fundy Medical Supplies
647497 Future Dream Ventures
647814 GAIA DESIGNS
647629 GALLERY CONNEXION Organization
of the Development of Artists
647686 Garage Jacques Michaud
647802 Garderie La cour des grands
647642 GEMM Home Builders & Design
648358 Gentle Touch Footcare
615832 girvanmedia
615696 GLASSWERX NEON SIGNS
615576 Gordon Cowan Plumbing
609385 Grace Adventures
647782 Gray Wolf Photos
648166 GROVE HILL CONSULTING
647771 GUMWIZARD
647911 HARMONY HOUSE VENTURES
648217 Hartt Island RV Resort
609527 Heavenly Gowns Bridal Boutique &
Formal Wear
648168 Hennigar & Associates Consulting
615596 HI VENTURE FARMS
647614 HIGH FIVE Early Learning Centre
647514 Howe Technological Services
647532 IATC Marketing and Consulting
609719 ING Novex
648432 Integrity Investigations and Document
Service
647866 Intuitive Energy
647928 iSpark Creative Adventures
615840 J. F. Balcomb & Associates
647766 JETPAC Marketing Solutions
609616 JG Comeau & Associates
648207 Jill Little Design
615746 JKM Special Care Home
647315 Jmailer
647673 Joan & J Pet Styling
647651 JOLI Laser Aesthetics
345713 Juniper Construction
647871 K & D Property Maintenance
647865 KamDEN Graphics & Promotions
648093 KAMM-LAB
648094 KAMM-LAB MEDICAL
LABORATORY SERVICES
648150 Kelly’s Repair & Service Centre
648489 KEVIN’S GARAGE & TOWING
648491 KEVIN’S TRUCKING
609279 KFC
615631 Kim’s Hair Design
648141 Kimble Convenience
609447 KING STREET SPORTS
647845 Kings Chapel Funeral Home & Cremation
Centre
648418 Kings Way LifeCare Alliance
647849 Kingsclear Construction
648297 Knots Be Gone Massage
648124 Know Fire Canada
337639 L’ACADIE NOUVELLE
647810 L’AUDACIEUSE CUISINE
648086 L5 Media
647698 La Mijoterie
647499 LA SPOT DES PÊCHEURS
647689 Le Centre de Soins au Palace
647634 Le Réseau des Échos du Nouveau-
Brunswick
345823 LeeCom Enterprises
615793 Les Chalets-sur-Mer enrg.
647523 LIL’ NASHIRA MASSAGE
647915 Lise Gallant Bookkeeping Services
647763 Location Daniel Lepage Rental
615842 LONGHORN TRANSPORTATION
648184 Lydon Consulting
648433 Lynn’s Eyebrow Clinic
615770 M & B BLUEBERRY FARMS
647654 M D S WHOLESALERS
648296 M.R.M. Custom Woodwork
647397 MACONNERIE BEL ROC ENR
348233 MADILL’S REFRIGERATION & AIR
CONDITIONING
648177 Man Around the House Home
Renovations
648275 MAPPINS JEWELLERS
648187 Marc Gould Trucking
645792 mariages créAtioNIK weddings
648265 Maritime Mobile Dj Services
647372 Mary Lou’s Blood Collection Service
647854 MATTCAN TRANSPORT
647858 Max Income Tax
343176 MCVAN ENTERPRISES
648165 Merynic Consulting
647568 Michael Code Insurance
647558 Mighty Duct Cleaners
610169 Mill Cove Convenience
615618 Milled Rite Lumber
647798 MITCHELL HAYNES CONTRACTING
647741 MMMarvellous MMMuffins
647740 MMMuffins
648130 MONCTON PARK N SELL
647536 Mondrian
647537 Mondrian-Hall
647747 Monsieur Bibitte
647526 MORTON PUB
647907 MOUNT PLEASANT VILLAGE
648179 Mr. Movie
648096 MSR Marketing & Sales Agency
615643 Mukonda Canada Venture Partners
647594 My Work Site
331667 NBTel Mobile Office
331549 NBTel Mobility
331668 NBTel Optimizer
648142 Net Tech Solutions
648395 No Bells No Wall Learning - Apprendre
sans cloche sans mur
647674 Noella Fleuriste
648415 North End Auto Repair
615511 North Side Collision Miramichi
345745 NUSSEY CONSULTING
647608 OLD TIME CATERING
648149 One-Stop Electronics
648128 OX-BOW FARM
334903 P.W.F. TRANSPORTATION SERVICES
315925 PALADIN FINANCIAL SERVICES
648172 PC Home Canada
647581 PC Techworld
647580 PCTW Networking Group
647652 PEEL PUB
648270 PEOPLES JEWELLERS
335047 PETER DEMERCHANT GENERAL
CONSTRUCTION
641608 PHINNEY SALVAGE
The Royal Gazette — January 21, 2015 67 Gazette royale — 21 janvier 2015
648329 Phototropical by Valerie Biebuyck
609188 Pine Glen Designs
609277 Pizza Hut
647571 PLATINUM PARKING
MANAGEMENT SYSTEMS
647628 PMW Precision Machine Works
647648 Prince Edward Guardian
647600 PRINCESS BRIDE WEDDINGS
648325 Pro Dent
647680 PROMOTIONS BLANCHARD/
BLANCHARD PROMOTIONS
615430 PS Consulting
615732 QUINCY’S ELECTRIC
647730 R & B Under The Red Roof
335072 R M B TECH
609317 RACHELLE’S CUTS & CREATIONS
648266 RBG Consulting
615849 Re/Max Hartford Realty
647314 Red Door Smokin’ Supplies
647609 REEDS POINT PUB & GRILL
647944 Renar Animation
648463 Repair Pro Auto
648206 Résidence chêne de Mambré
648474 RetroReplay
310815 RITEWAY AUTO LEASING
332667 ROBBIE O’NEILL ENTERPRISES
646254 Robert Breau Ferme
615848 Robins Inn
647553 Rogers No Frills
609637 Rogersville Auto Salvage
647939 S.T.A.R. SOUND THE ALARM
RECORDING STUDIO
609303 Saint John College
609267 SAINT JOHN LASER CLINIC
647850 Salon Coiffure Centre-Ville
615223 Salon Mexicut
648308 Sammy’s Forest Management
648420 SAPUTO DIVISION PRODUITS
LAITIERS (CANADA) / SAPUTO
DAIRY PRODUCTS DIVISION
(CANADA)
647682 Savi Jewelry
609612 Scierie BLT
647905 Sécurité Financière André Gallant
Financial Security
609417 Seeking Balance
646819 SELECT BEAUTY SUPPLIES
647808 Shediac Glass & Maintenance
610166 Shiretown Image Maker
647791 Sinderella’s Toy Box
647583 Sistema Canada
647584 Sistema New Brunswick
648089 Solar Smart Solutions
647855 South East Energy
348168 SPOTLESS JANITORIAL
609290 STUDENT TAXI
647586 SUE’S COUNTRY NOOK
646936 Swath Custom Cutlery Forge and
Rehoning
647891 SYNERGYSCREENS
609278 Taco Bell
648334 Tall Oaks Administrative Services
332604 THE AUCTION CENTER
648105 The Big Clean
648216 The Bucket Club Outdoor Activity Park
609333 The Buckley’s Company / la compagnie
Buckley
615509 the Computer Aided Bookkeeping
company
316198 THE GOODIE SHOP
647559 The Great Canadian Pub Lounge
300380 THE HILLTOP PUB
615822 THE SIDE BAR
648147 The Tin Can Convenience Store
648402 The Vintage Rose
609349 Three Apples Arts and Crafts
648237 TINA’S ISLAND MARKET
348114 TOP DECK RESTAURANT
647493 Top Flight Mortgage Centre
348135 TOP OF THE TOWN
647577 Torsten Linke Trucking
647646 Total S.P.O.R.T. Centres
647940 Totten Trucking
648309 TRIMACK PROPERTY CARE
608420 TRIUS TAXI
648208 Twilight Night Club
648323 Tycho Computers
647599 TYTECH SOLUTIONS
609342 V-GOLF
608735 VCS COST MANAGEMENT
SOLUTIONS
615733 VF CANADA
646985 VIENNEAU QUALITY
MERCHANDISE
648083 Vinny’s Chip Truck
609448 Violette Dental Health
647704 Vision Plus
647968 VisionA Consultants
647974 Viva Mode
648261 Wall Property Services
615662 WASHADEMOAK COMMUNITY
CALENDAR
609435 Water Metrics
609222 WEIR’S MACHINE SHOP
647859 Windy Hollow Enterprises
647480 WINTERWOOD NATURAL FOODS
647495 WitsEye Publishing
647857 WOODSIDE STABLE
647690 Woodstock Main Street Convenience
609524 WORKIN FOLK ART
DRE JOËLLE DROLET-FERGUSON C.P. INC. Tracadie-Sheila 679937 2015 01 01
Elite 1 MMA Productions Inc. Lakeville 679960 2014 12 15
Boutique Bébé tout neuf inc. Haut-Lamèque 679983 2015 01 01
C. S. Technologies Group Inc. Saint John 680038 2014 12 17
Reference marketing URLs Inc. Saint John 680040 2014 12 17
GESTION PAUL LECLERC INC. Grand-Sault / Grand Falls 680077 2015 01 01
Newmarket Forest Ventures Ltd. Brockway 680079 2015 01 01
Dr. Louis Juravsky Professional Corporation Moncton 680085 2015 01 01
680087 N.B. Inc. Lutes Mountain 680087 2014 12 19
Pro Fuel Plus Ltd. Caraquet 680093 2014 12 19
680094 NB INC. Miramichi 680094 2014 12 19
Loi sur les corporations
commerciales
Business Corporations Act
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of incorporation has been issued to: SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commer-
ciales, un certificat de constitution en corporation a été émis à :
Reference
Number Date
Registered Office Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour
The Royal Gazette — January 21, 2015 68 Gazette royale — 21 janvier 2015
THERRIEN FABRICATION INC. Edmundston 680095 2014 12 19
680096 NB INC. Miramichi 680096 2014 12 19
TLG Bookkeeping Services Inc. Bathurst 680097 2014 12 19
K & R ELECTRICAL SERVICES INC. Grande-Anse 680101 2014 12 22
Savarin Holdings Limited Saint John 680102 2014 12 22
A.R. Léger Holdings Inc. Moncton 680108 2014 12 22
680115 NB Inc. Lepreau 680115 2014 12 22
680116 NB INC. Saint-Léonard 680116 2014 12 22
Hutt Chiropractic Professional Corporation Miramichi 680117 2014 12 22
Jackie A. Dableh-Hakimian CPA Professional Corporation Fredericton 680119 2015 01 01
680122 N.B. LTD. Douglas 680122 2014 12 22
M.J. Connors P.C. Incorporated Fredericton 680125 2014 12 29
M.J. Connors Services P.C. Incorporated Fredericton 680126 2014 12 29
680127 NB Ltd. Dieppe 680127 2014 12 22
680128 NB Ltd. Riverview 680128 2014 12 22
680129 N.B. Ltd. Fredericton 680129 2014 12 22
AVG Consulting & Bookkeeping Ltd. Moncton 680132 2014 12 22
MAPLE A.L. INC. Saint-Quentin 680134 2014 12 22
Ego Modern Beauty Ltd. Fredericton 680137 2014 12 22
A.W.O.L. BREWERY CORP. Riverview 680138 2014 12 22
Liv9 Nutrition Inc. Nackawic 680141 2014 12 22
680142 N.B. Inc. Saint John 680142 2014 12 22
680144 NB INC. Fredericton 680144 2014 12 23
680147 N.B. INC. Miramichi 680147 2014 12 23
680148 N.B. Inc. Moncton 680148 2014 12 23
Tough Guy Brewing Inc. Fredericton 680149 2014 12 23
680150 NB INC. Fredericton 680150 2014 12 23
680152 NB INC. Sackville 680152 2014 12 23
680153 NB INC. Sackville 680153 2014 12 23
680154 N.B. Ltd. Sussex 680154 2014 12 23
GAR Holdings Inc. Sackville 680160 2014 12 23
680161 N.B. Inc. Fredericton 680161 2014 12 23
M. Chiasson P.C. Incorporated Moncton 680162 2014 12 29
KPC Holdings Inc. Sackville 680163 2014 12 23
M. Chiasson Services P.C. Incorporated Moncton 680164 2014 12 29
BANKERS CAPITAL CANADA LTD. Moncton 680165 2014 12 23
680166 NB Ltd. Moncton 680166 2014 12 23
The Royal Gazette — January 21, 2015 69 Gazette royale — 21 janvier 2015
Dr. Vineeta Sethi P.C. Inc. Fredericton 680167 2014 12 23
R.M. Boudreau P.C. Incorporated Moncton 680174 2014 12 29
R.M. Boudreau Services P.C. Incorporated Moncton 680176 2014 12 29
680177 NB Inc. Monteagle 680177 2014 12 23
Jill Stairs Professional Corporation Fredericton 680179 2014 12 23
Down East Window & Door Ltd. Sussex 680180 2014 12 23
Bronzage Zana inc. Kedgwick 680181 2014 12 23
680182 NB INC. Campbellton 680182 2015 01 01
Coreys Towing Ltd. Petitcodiac 680183 2014 12 24
RONALD J. SAVOY PROFESSIONAL CORPORATION Moncton 680184 2014 12 31
EMMY CHIASSON PROFESSIONAL CORPORATION Moncton 680186 2014 12 31
Carrot Global Canada Limited Fredericton 680189 2014 12 26
Seymour Holdings Ltd. Fredericton 680200 2014 12 29
680211 NB LTD. Grafton 680211 2014 12 29
Calumniam Consulting Inc. Fredericton 680212 2014 12 29
680214 NB Ltd. Moncton 680214 2014 12 29
680223 NB Inc. Fredericton 680223 2014 12 30
Silver Mountain Targets Inc. Keswick Ridge 680224 2014 12 30
Redgrey Consulting Inc. Fredericton 680225 2014 12 30
ALDAN Holdings Inc. Fredericton 680226 2014 12 30
680228 N.B. Inc. Saint John 680228 2014 12 30
680236 NB Inc. Fredericton 680236 2014 12 30
680237 NB Ltd. Grand Bay-Westfield 680237 2014 12 30
Kaajenga Inc. Moncton 680238 2014 12 30
Peter E. Crocco Professional Corporation Woodstock 680239 2014 12 30
680240 N.B. INC. Oak Bay 680240 2014 12 30
Advance Care Canada Limited Rothesay 680247 2014 12 30
DARCY D & D HOLDING CO. LTD. Keswick Ridge 680256 2014 12 31
Candle in the Window Primitives Inc. Boiestown 680257 2014 12 31
Oak Haven Auto Renewal Ltd. Oak Haven 680272 2014 12 31
Design Right Canada Ltd. Saint John 680278 2015 01 01
D. Armstrong Professional Corporation Fredericton 680279 2015 01 01
680280 NB Holdings (539474) Inc. Fredericton 680280 2015 01 01
Dr. Jennifer Landry Professional Corporation Saint John 680281 2014 12 31
680282 N.B. Ltd. Saint John 680282 2014 12 31
MATTHEW G. DERRAH, CPA, CA PROFESSIONAL
CORPORATION Woodstock 680284 2015 01 02
The Royal Gazette — January 21, 2015 70 Gazette royale — 21 janvier 2015
NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUM
Business Corporations Act / Loi sur les corporations commerciales
In relation to a certificate of incorporation issued on December 15, 2014 under the name of “Premier Shuttle Inc.”, being corporation #679961,
notice is given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of incorporation correcting the name of the incorporator
from “Jean Dbé” to “Jean Dubé”.
Sachez que, relativement au certificat de constitution en corporation délivré le 15 décembre 2014 à « Premier Shuttle Inc. », dont le numéro de
corporation est 679961, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat d’incorporation corrigé faisant passer le nom du
fondateur de «Jean Dbé» à « Jean Dubé ».
_____________________________________________________
In relation to a certificate of incorporation issued on December 16, 2014 under the name of “Future Bridge Inc.”, being corporation #679984, notice
is given that pursuant to s. 189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of incorporation correcting the name of one of the directors
from “Sonh Trinhto “Son Trinh” and also correcting the address of another director.
Sachez que, relativement au certificat de constitution en corporation délivré le 16 décembre 2014 à « Future Bridge Inc. », dont le numéro de cor-
poration est 679984, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat d’incorporation corrigé faisant passer le nom d’un
des administrateurs de «Sonh Trin à «Son Trin et corrigeant aussi l’adresse d’un des autres administrateurs.
_____________________________________________________
In relation to a certificate of incorporation issued on December 16, 2014 under the name of “Prosharp Inc.”, being corporation #679985, notice is
given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of incorporation correcting the “Schedule – Other Provisions
/ Annexe – D’autres dispositions” to the attached articles.
Sachez que, relativement au certificat de constitution en corporation délivré le 16 décembre 2014 à « Prosharp Inc. », dont le numéro de corporation
est 679985, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat d’incorporation corrigé corrigeant le « Schedule – Other
Provisions / Annexe – D’autres dispositions » dans les articles ci-joints.
_____________________________________________________
MICHAEL R. CORMIER P.C. INC. Moncton 680287 2015 01 02
680295 NB Ltd. Fredericton 680295 2015 01 02
MARITIME BERRIES LIMITED Sackville Nouvelle-Écosse /
Nova Scotia 680139 2014 12 22
IOC Oil Holdings Limited Saint John Ontario 680143 2014 12 22
MMC INSURANCE SERVICES LIMITED Moncton Nouvelle-Écosse /
Nova Scotia 680146 2014 12 19
_____________________________________________________
BRIAN HARRIS INSURANCE LTD. 007810 2014 12 23
B. & A. YOUNG LTD. 010421 2014 12 22
QUALITY SOUND ALARM LTD. 013518 2014 12 22
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpo-
rations Act, a certificate of continuance has been issued to: SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de prorogation a été émis à :
Previous Reference
Jurisdiction Number Date
Registered Office Compétence Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Bureau enregistré antérieure référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of amendment has been issued to: SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de modification a été émis à :
Date
Reference Number Year Month Day
Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour
The Royal Gazette — January 21, 2015 71 Gazette royale — 21 janvier 2015
COX’S HOLDINGS LTD. 031202 2014 12 29
BLUECORP INC. 038434 2014 12 29
040877 N.B. LTD. 040877 2014 12 29
ROGERSVILLE ARCTIC SPORTS LTD. 041261 2014 12 30
JAMCO CONTRACTING LTD. 041337 2014 12 22
JARDINE AUCTIONEERS INC. 046222 2014 12 30
PODOCO LTEE 047938 2014 12 22
K. & I. FOOD SERVICES LTD. 052237 2014 12 19
VOLUSIA ENTERPRISES INC. 055430 2014 12 19
MIKE START HOLDINGS INC. 057995 2014 12 22
SOUTHERN SANITATION LTD 502201 2014 12 31
PROFESSIONAL QUALITY ASSURANCE LTD. 505741 2014 12 22
507877 N.B. LTD. 507877 2014 12 23
Financial Foundations Inc. 509729 2014 12 23
I. & G. Food Services Ltd. 512895 2014 12 19
Maritime Communication Services (N.B.) Ltd. 513121 2014 12 22
J.M.L. Garage Ltée 604203 2014 12 22
Place Broadway Ltée - Broadway Place Ltd. 610146 2014 12 23
CORPORATION PROFESSIONNELLE DR. PAUL LECLERC INC. 621453 2015 01 01
TOSS Architecture Inc. 622523 2014 12 22
New River Holdings Inc. 629063 2014 12 23
BASEK Hurley Holdings Ltd. 630946 2014 12 23
634939 N.B. Inc. 634939 2014 12 19
635497 N.B. Inc. 635497 2014 12 23
635498 N.B. Inc. 635498 2014 12 23
ENERCHECK SOLUTIONS INC. 636777 2014 12 23
ESR INVESTMENTS INC. 640906 2015 01 02
Assurance Sylvio Leclerc Inc. 641245 2014 12 22
K. Watt & Associates Inc. 642897 2014 12 23
Moosehead Breweries Limited 643823 2014 12 23
JOEY’S PUB & EATERY INC. 645519 2014 12 19
PVC Home Builders Ltd. 650875 2014 12 22
663683 N.B. Inc./ 663683 N.-B. Inc. 663683 2014 12 31
North of Sixty Art Ltd. 667626 2014 12 24
New Steffeshof Farms 2013 Ltd. 670028 2014 12 23
Scheele Holding Ltd. 670030 2014 12 23
673969 NB Inc. 673969 2014 12 23
The Royal Gazette — January 21, 2015 72 Gazette royale — 21 janvier 2015
NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUM
Business Corporations Act / Loi sur les corporations commerciales
In relation to a certificate of amendment issued on Dcember 22, 2014 under the name of “B. & A. YOUNG LTD.”, being corporation #010421,
notice is given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of amendment amending the “Schedule – Share Struc-
ture / Annexe – Organisation du capital social” to the attached articles.
Sachez que, relativement au certificat de modification délivré le 22 décembre 2014 à « B. & A. YOUNG LTD. », dont le numéro de corporation est
010421, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat corrigé de modification modifiant le « Schedule – Share Struc-
ture / Annexe – Organisation du capital social » dans les articles ci-joints.
_____________________________________________________
D. WHALEN CONSULTING FIRM INC. 676898 2014 12 23
680076 N.B. Inc. 680076 2014 12 23
22 King Street Inc. GILMAC MANAGEMENT LTD. 034221 2015 01 02
East Glassville Holdings Ltd. Calvin D. Anderson & Son Inc. 046691 2014 12 29
Steeves Porter Hetu & Associates Inc. DALE B. STEEVES PROFESSIONAL
CORPORATION 059037 2014 12 23
FITSTATS TECHNOLOGIES, INC. ADVANCED FITNESS DESIGNS Inc 512670 2014 12 30
G. & S. Holdings Inc. EXCEL Pest Control LTD. 512934 2014 12 31
Bluecorp (2015) Inc. Bluecorp Realty Inc. 513252 2015 01 01
JMN ENTERPRISES INC. ATELIER LANDRY INC. 513602 2014 12 23
514313 N.B. Inc. Domaine Parlee Beach Inc. 514313 2015 01 01
TriStar Fine Cars Inc. 613735 NB INC. 613735 2015 01 01
M2 Project Builders Inc. EcoTek Homes Ltd. 631710 2014 12 29
DLN Investments Inc. Dr. Nidal Chami C.P. Inc. 650863 2014 12 22
B&J Auto Services Inc. 657565 N.B. LTD. 657565 2014 12 23
661352 N.B. LTD. OLEARY BUICK GMC LTD. 661352 2014 12 22
UWI Holdings Corporation Australian Sapphire Corporation 670570 2014 12 23
E STYLE PRO INC. Nineteen E-Cigarette & Accessories Inc. 677433 2014 12 19
McDEL LANDSCAPING AND SNOW
REMOVAL CO. INC. 679321 NB Inc. 679321 2014 12 22
Shy Lady Fisheries Ltd. 679350 N.B. Ltd. 679350 2014 12 23
Hayoli Fisheries Ltd. 679359 N.B. Ltd. 679359 2014 12 29
EASTWIND BUSINESS SOLUTIONS INC. FLAGSTAFF HOLDINGS INC. 679970 2015 01 01
Campbellton Hardware Inc. MCO Holding Inc. 680133 2015 01 01
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of amendment which includes a change in
name has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de modification contenant un changement de raison
sociale a été émis à :
Date
Previous name Reference Number Year Month Day
Name / Raison sociale Ancienne raison sociale Numéro de référence année mois jour
The Royal Gazette — January 21, 2015 73 Gazette royale — 21 janvier 2015
BelleBay Holdings Inc. 679710 N.B. Inc. 680159 2014 12 25
Harvey Insurance Ltd. 648490 NB Inc. 680199 2014 12 31
_____________________________________________________
Mirisa Holdings Inc. Darrell J. Stephenson Professional
Corporation
D.J. Stephenson P.C. Inc.
Rothesay 679885 2015 01 01
Eastern Compactor Services Ltd. PENNFIELD LOGGING LTD.
Eastern Compactor Services Ltd. Lutes Mountain 679945 2015 01 01
Chaisson Lemoine Professional Chaisson Lemoine Professional
Corporation
679214 N.B. Inc.
Saint John 679969 2014 12 31
FLAGSTAFF HOLDINGS INC. Eastwind Business Solutions Inc.
FLAGSTAFF HOLDINGS INC. Petitcodiac 679970 2015 01 01
ANDRITZ HYDRO CANADA INC. Andritz Hydro Canada Inc.
Andritz Hydro Ltée./Andritz Hydro Ltd. Saint John 680030 2015 01 01
ÉPICERIE LEBRETON (2014) LTÉE Epicerie LeBreton 1998 Ltée
679605 NB INC. Shippagan 680031 2014 12 31
649850 N.B. Ltd. 051536 N. B. LTD.
649850 N.B. Ltd. Moncton 680044 2015 01 01
GENERAL FINANCIAL CORPORATION
LTD. 514313 N.B. Inc.
602867 N.B. LTD.
GENERAL FINANCIAL
CORPORATION LTD.
Shediac 680048 2015 01 01
Jean-Marc Gauvin C.P. Inc. GO-20 INC.
059892 NB Inc.
Jean-Marc Gauvin C.P. Inc.
Saint-Simon 680068 2015 01 01
FPM HOLDING INC. CLARENCE DAIGLE & FILS LTEE -
CLARENCE DAIGLE & SONS LTD.
J.J. CONSTRUCTION & LEASING
CO. LTD.
FPM HOLDING INC.
Edmundston 680082 2015 01 01
MONCTON FISH MARKET LTD. MONCTON FISH MARKET LTD.
629697 N.B. Inc.
629700 N.B. Inc.
Moncton 680083 2014 12 23
R. & D. ENTERPRISES LTD. R. & D. ENTERPRISES LTD.
679835 NB INC. Campbellton 680090 2015 01 01
Irving Consumer Products Limited
Les Produits de Consommation
Irving Limitée
Irving Tissue Corporation
Les Papiers Irving Incorporée
Irving Personal Care Limited
Les Soins Personnels Irving Limitée
Irving Consumer Products Limited
Les Produits de Consommation
Irving Limitée
Saint John 680104 2015 01 01
Coast Tire & Auto Service Ltd. COAST TIRE (FAIRVILLE BLVD.)
LTD.
Coast Tire & Auto Service Ltd.
Saint John 680114 2015 01 01
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of amalgamation has been issued to: SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de fusion a été émis à :
Reference
Number Date
Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Registered Office Numéro de Year Month Day
Corporation issue de la fusion Corporations fusionnantes Bureau enregist référence année mois jour
The Royal Gazette — January 21, 2015 74 Gazette royale — 21 janvier 2015
MCO Holding Inc. MCO HOLDING INC.
CAMPBELLTON HARDWARE INC. Campbellton 680133 2015 01 01
LA CAUSERIE AMICALE INC. Sunflower Patch Daycare Inc. /
Garderie Jardin de Tournesols Inc.
Friendship Circle DayCare Inc. /
Garderie Le Cercle d’Amitié Inc.
La Causerie Amicale Inc.
Cocagne 680135 2015 01 01
R & D Zinck Holdings Ltd. 501932 N.B. Inc.
R & D ZINCK HOLDINGS LTD.
CTB Holdings Ltd.
649103 N.B. Inc.
McLeod Hill 680140 2015 01 01
SNOKIST LTD. PRYOR FARMS LTD.
SNOKIST LTD. Hartford 680145 2015 01 01
679710 N.B. Inc. BelleBay Holdings Inc.
679710 N.B. Inc. Saint John 680159 2014 12 25
Family First Human Services Inc. FAMILY FIRST HUMAN SERVICES
INC.
674027 N.B. Inc.
Richibucto Road 680168 2015 01 01
Matt Holdings Ltd. M.F. ESSON & SONS, LIMITED
MATT HOLDINGS LTD. Hanwell 680187 2015 01 01
Max Health Institute and
Physiotherapy P.C. Inc./
Institut de la santé Max et
physiothérapie c.p. inc.
MAX Health Institute Inc. /
Institut de santé Max inc.
Max Health Institute and
Physiotherapy P.C. Inc./
Institut de la santé Max et
physiothérapie c.p. inc.
Dieppe 680194 2015 01 01
ASSURANCE VIENNEAU LTEE -
VIENNEAU INSURANCE LTD. ASSURANCE VIENNEAU LTEE -
VIENNEAU INSURANCE LTD.
Assurance Beauséjour Insurance
Ltée. - Assurance Beauséjour
Insurance Ltd.
Shediac 680195 2015 01 01
607198 N.B. LTD. 607198 N.B. LTD.
658229 N.B. INC. Bethel 680198 2015 01 01
648490 NB Inc. HARVEY INSURANCE LTD.
648490 NB Inc. Harvey Station 680199 2014 12 31
Power Engineers Canada, Inc. Power Food Consulting, Inc.
Power Engineers Canada, Inc. Fredericton 680203 2015 01 01
C.J. Poirier Entreprises Ltée PODOCO LTEE
C.J. POIRIER ENTREPRISES LTÉE Grand-Barachois 680230 2015 01 01
SHEPODY BERRY & LUMBER,
CO. LTD. SACKVILLE MEDICAL REALTIES
LTD.
SHEPODY BERRY & LUMBER, CO.,
LTD.
MARITIME BERRIES LIMITED
Sackville 680231 2015 01 01
629856 N.B. Ltd. 629856 N.B. LTD.
654845 N.B. Ltd.
654847 N.B. Ltd.
Moncton 680232 2014 12 31
Scan Air Balance (1998) Ltd. Scan Air Balance (1998) Ltd.
661252 NB LTD. Moncton 680233 2015 01 01
David McCarthy Ltd. DAVID MCCARTHY LTD.
Ebbett Farms Limited Upper Kent 680234 2015 01 01
On The Trail Adventures Ltd. Northway Outfitters Ltd.
On The Trail Adventures Ltd. Windsor 680235 2015 01 01
The Royal Gazette — January 21, 2015 75 Gazette royale — 21 janvier 2015
BACK BAY SALMON LTD. BACK BAY SEA URCHINS LTD.
BACK BAY SALMON LTD. Back Bay 680244 2015 01 01
Xplornet Communications Inc. Xplornet Broadband Inc.
632527 New Brunswick Inc.
Xplornet Communications Inc.
Woodstock 680246 2015 01 01
Lounsbury Company Limited Lucien LeBlanc Holdings Inc.
Lounsbury Company Limited Moncton 680250 2015 01 01
Lounsbury Company Limited C. H. S. Holdings Inc.
Lounsbury Company Limited Moncton 680251 2015 01 01
New Brunswick EMS Inc. BLUECORP INC.
New Brunswick EMS Inc.
MMC INSURANCE SERVICES
LIMITED
Moncton 680253 2015 01 01
CRESCENT (1952) LIMITED CRESCENT (1952) LIMITED
667090 NB LTD. Hartland 680254 2015 01 01
Omer LeBlanc & Son Ltd./Ltée OMER LEBLANC & SON LTD/LTEE
MARITIME ROOF SYSTEMS LTD./
SYSTEME DE TOIT MARITIME
LTEE.
Dalhousie 680260 2015 01 01
HOWLAND HOLDINGS LTD. HOWLAND HOLDINGS LTD.
BELLEISLE LEASING LTD. Quispamsis 680262 2014 12 31
Charles & Marthe Investments Inc. Pharmacie Richard Pharmacy Inc.
Charles & Marthe Investments Inc. Saint-Louis-de- 680263 2015 01 01
Kent
G. Lemieux & A. Ménard P.C. Inc. J. Gilles Lemieux Corporation
Professionnelle Inc./ Professional
Corporation
Alison J. Ménard P.C. Inc.
Saint-Antoine 680264 2015 01 01
CFMO Company Limited CFMO Company Limited
CFME Company Limited
IOC Oil Holdings Limited
Saint John 680266 2015 01 01
Brett Chevrolet Cadillac Buick 058928 N.B. INC.
Brett Chevrolet Cadillac Buick GMC
Ltd.
Saint John 680269 2015 01 01
056632 N.B. LTD. 056632 N.B. LTD.
Saint John Auto Auction Ltd.
653760 N.B. INC.
661765 N.B. Ltd.
Rusagonis 680270 2015 01 01
Briggs & Little Woolen Mills Ltd. BRIGGS & LITTLE WOOLEN MILLS
LTD.
JOHN LITTLE HOLDINGS LTD.
Harvey 680271 2015 01 01
Restigouche Court Development Inc. RESTIGOUCHE COURT
DEVELOPMENT INC.
Maximum Paving Inc.
Campbellton 680274 2015 01 01
Meubles J.R. Lagacé Inc. Meubles J.R. Lagacé Inc.
MEUBLES EKO FURNITURE INC. Campbellton 680276 2015 01 01
RIJON INVESTMENTS LTD. RIJON INVESTMENTS LTD.
JONRI MANAGEMENT LTD. Saint John 680285 2015 01 02
_____________________________________________________
The Royal Gazette — January 21, 2015 76 Gazette royale — 21 janvier 2015
COASTAL CANADA PETROLEUM, INC.
PETROLE COASTAL CANADA, INC. Saint John 057264 2014 12 19
Sterling Electronic Commerce (Canada), Inc./
Commerce Electronique Sterling (Canada) Inc. Saint John 608455 2014 12 30
Dollarama Corporation Saint John 615595 2014 12 18
W. E. P. Edwards Consulting Solutions Inc. Saint John 636383 2014 12 29
R.A. Soucy Consultants Inc. Edmundston 638626 2014 12 19
JOHNSTON’S TOWING & RECOVERY INC. Sussex Corner 644060 2014 12 31
Apex Tool Holding Canada 3 Ltd. Saint John 651136 2014 12 31
Dre Nadine Kabwe Kiti C.P. Inc. Edmundston 659435 2014 12 19
_____________________________________________________
T.M.M. Fabrication Inc. 047026 2014 12 22
_____________________________________________________
Pneus ABC Tires Inc. Atholville POWELL ASSOCIATES LTD. 621674 2014 12 22
_____________________________________________________
Distribution 83 PPM Inc. Québec / Quebec 514356 2014 12 22
THE NIGHT SHIFT ANSWERING SERVICE
LTD. Colombie-Britannique /
British Columbia 626338 2014 12 12
PT Health NB Professional Corporation Canada 662997 2014 12 11
_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of dissolution has been issued to: SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de dissolution a été émis à :
Reference
Number Date
Registered Office Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a restated certificate of incorporation has been issued to: SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de constitution mise à jour a été émis à :
Date
Reference Number Year Month Day
Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, notice of the discharge of a receiver or a receiver-
manager of the following corporations has been received:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un avis de libération d’un séquestre ou séquestre-gérant pour les
sociétés suivantes a été reçu :
Receiver or Reference
Receiver-Manager Number Date
Registered Office questre ou Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Bureau enregistré séquestre-gérant férence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of discontinuance has been issued to: SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de cessation a été émis à :
Date
Jurisdiction of Continuance Reference Number Year Month Day
Name / Raison sociale Compétence de prorogation Numéro de référence année mois jour
The Royal Gazette — January 21, 2015 77 Gazette royale — 21 janvier 2015
BILL A’COURT SALES LTD. 501819 2014 12 22
Hugh Investment Group Corporation 611487 2014 12 23
Ray of Light Daycare Inc. 660606 2014 12 22
_____________________________________________________
ANDREW ROBERTS PROFESSIONAL
CORPORATION LTD. Canada Andrew D.W. Roberts
Moncton 680045 2014 12 18
ALTIUS RESOURCES INC. Terre-Neuve et Labrador/
Newfoundland and
Labrador
McInnes Cooper
CSD Services Inc.
Fredericton
680103 2014 12 19
Escalade Wines & Spirits Inc. Ontario Stewart McKelvey Corporate
Services (NB) Inc.
Saint John
680113 2014 12 22
9108483 Canada Inc. Canada Donald J. Stevenson
Fredericton 680130 2014 12 22
Fjallraven USA, LLC New York Stewart McKelvey Corporate
Services (NB) Inc.
Saint John
680156 2014 12 23
9122800 Canada Inc. Canada Trevor Cookson
Fredericton 680178 2014 12 23
GGR Finance Inc. Ontario Jay Phinney
Saint John 680196 2014 12 29
Eckler Ltd./Eckler ltée Ontario Arthur T. Doyle
Saint John 680197 2014 12 29
ENTREPRISES JOCELYNE FAUVEL
INC. Canada Jocelyne Fauvel
Pointe-Alexandre 680204 2014 12 29
9116869 Canada Corporation Canada René Basque
Moncton 680210 2014 12 29
_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of revival has been issued to: SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de reconstitution a été émis à :
Date
Reference Number Year Month Day
Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of registration of extra-provincial corporation
has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat d’enregistrement de corporation extraprovinciale a été
émis à :
Reference
Number Date
Jurisdiction Agent and Address Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Compétence Représentant et adresse référence année mois jour
The Royal Gazette — January 21, 2015 78 Gazette royale — 21 janvier 2015
IRI-Aztec (Canada) Ltd. Aztec Information Services (Canada) Limited 672195 2014 12 23
_____________________________________________________
MGA Partners Inc. MGA Partners Inc. Stewart McKelvey
Corporate Services
(NB) Inc.
Saint John
680022 2014 12 17
MGA Partners Inc. MGA Partners Inc. Stewart McKelvey
Corporate Services
(NB) Inc.
Saint John
680023 2014 12 17
SLEEMAN BREWERIES LTD./
BRASSERIE SLEEMAN LTEE SLEEMAN BREWERIES LTD.
BRASSERIE SLEEMAN LTEE Willard M. Jenkins
Saint John 680220 2014 12 29
Santélo Inc. Edmundston 680089 2014 12 19
FRIENDS OF KENNEBECASIS VALLEY LIBRARY INC. Quispamsis 680172 2014 12 23
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of amendment of registration of extra-
provincial corporation has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de modification de l’enregistrement de corporation
extraprovinciale a été émis à :
Reference
Number Date
Previous name Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Ancienne raison sociale référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of registration of amalgamated corporation
has been issued to the following extra-provincial corporations:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat d’enregistrement d’une corporation extraprovinciale
issue de la fusion a été émis aux corporations extraprovinciales sui-
vantes :
Reference
Agent and Address Number Date
Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Représentant et Numéro de Year Month Day
Corporation issue de la fusion Corporations fusionnantes adresse référence année mois jour
Loi sur les compagniesCompanies Act
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,
letters patent have been granted to: SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres
patentes ont été émises à :
Reference
Number Date
Head Office Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Siège social férence année mois jour
The Royal Gazette — January 21, 2015 79 Gazette royale — 21 janvier 2015
Crafts Trucking Thomas M. Craft Saint John 679532 2014 11 19
Matrix North American
Construction Matrix SME Canada ULC Saint John 679954 2015 01 01
You-Mist-It Vape Store Sophia Macleod Moncton 679976 2014 12 16
Vacation Express Canada Sunwing Vacations Inc./
Vacances Sunwing Inc. Saint John 680000 2014 12 17
The Blake Wealth Management
Group Dundee Securities Ltd./
Valeurs Mobilieres Dundee ltee Saint John 680007 2014 12 17
Forgeron Régis Haché gis Haché Losier Settlement 680033 2014 12 17
SMS Ventilation Shirley Morin Saint-Joseph 680035 2014 12 29
Inn Thyme Lodging 678836 NB Inc. Shediac 680046 2014 12 18
Auberge Inn Thyme 678836 NB Inc. Shediac 680047 2014 12 18
Atlantic Quality & Technical
Services Atlantic Quality & Technical
Services Inc.
Les Services Techniques & De
Qualité Atlantiques Inc.
Saint John 680062 2014 12 18
SYNERGY DESIGNS GRAYSIA WEB SITE DESIGN
AND VIRTUAL ASSISTANT
SERVICES INC.
Sussex 680063 2014 12 18
Signature Pre-Owned Auto
Gallery 045502 N. B. LTD. Saint John 680065 2014 12 18
Maritime Oysters N.B. M.R. JAILLET ENTERPRISES
INC. Saint-Joseph-de-Kent 680066 2014 12 18
Doctors Orders:
Rehabilitation Canes 676855 New Brunswick Inc. Fredericton 680067 2014 12 18
Andrew C Electric Heather Long Riverview 680075 2014 12 18
DOYEN TECHNICAL Pragmantis Group Inc. Saint John 680091 2014 12 19
PATRICK RICHARDS
PHOTOGRAPHY Pragmantis Group Inc. Saint John 680092 2014 12 19
Kira M Painting Kira McLean Fredericton 680098 2014 12 20
Chaleur Shamrock East/West
Applications Ray Ed Dawson Dalhousie 680099 2014 12 20
HughGarse FoodTruck Kevin Robert Salisbury 680100 2014 12 20
Les Produits de Consommation
Irving Irving Consumer Products
Limited Les Produits de
Consommation Irving Limitée
Dieppe 680105 2015 01 01
Loi sur l’enregistrement des
sociétés en nom collectif et des
appellations commerciales
Partnerships and Business Names
Registration Act
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and
Business Names Registration Act, a certificate of business name has
been registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en
nom collectif et des appellations commerciales, un certificat d’appel-
lation commerciale a été enregistré :
Registrant of Address of Business Reference
Certificate or Agent Number Date
Enregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour
The Royal Gazette — January 21, 2015 80 Gazette royale — 21 janvier 2015
Irving Consumer Products Irving Consumer Products
Limited Les Produits de
Consommation Irving Limitée
Dieppe 680106 2015 01 01
Les Soins Personnels Irving Irving Consumer Products
Limited Les Produits de
Consommation Irving Limitée
Dieppe 680107 2015 01 01
Irving Personal Care Irving Consumer Products
Limited Les Produits de
Consommation Irving Limitée
Dieppe 680109 2015 01 01
Laqua Holdings Stephan Laqua Saint-Edouard-de-Kent 680118 2014 12 22
Jesters Tactical Sports Center Nathan Den Hollander Lincoln 680120 2014 12 22
Craft General Contracting Thomas Craft Saint John 680121 2014 12 22
Courtside Sneakers 9108483 Canada Inc. Fredericton 680131 2014 12 22
TOWNE AUTO CENTER Towne Sales and Service
Limited Napan 680136 2014 12 22
Kelly L. Buffett Law Office Kelly Buffett Fredericton 680151 2014 12 23
Fredericton Hyundai 679604 N.B. Ltd. Fredericton 680157 2014 12 23
OLeary Buick GMC 679603 N.B. Ltd. Fredericton 680158 2014 12 23
Ashford Auto Body Rodney Ashford Berry Mills 680175 2014 12 23
Evergreen Traders Trevor Rivett Fredericton 680185 2014 12 24
Dooly’s Sports Bar II 505342 N.B. LTD. Fredericton 680190 2014 12 29
Your Ideal Weigh 677858 N.B. Corp. Fredericton 680206 2014 12 29
CR Yardworks & Equipment Brandon Cox Riverview 680217 2014 12 29
Costello’s Plumbing & Heating Derrick Costello Miramichi 680219 2015 01 01
STROH BREWERY SLEEMAN BREWERIES LTD./
BRASSERIE SLEEMAN LTEE Saint John 680221 2014 12 29
SLEEMAN UNIBROUE SLEEMAN BREWERIES LTD./
BRASSERIE SLEEMAN LTEE Saint John 680222 2014 12 29
Rodolphe Monette Psychologue Rodolphe Monette Dieppe 680241 2014 12 31
IMB Apparel Sajid Butt Quispamsis 680255 2014 12 31
Lemieux Ménard & Co. G. Lemieux & A. Ménard P.C.
Inc. Saint-Antoine 680265 2015 01 01
FANCY COFFEE SERVICES Frederick A. Dixon Florenceville-Bristol 680273 2014 12 23
Maximum Paving Restigouche Court
Development Inc. Campbellton 680275 2015 01 01
Meubles EKO Furniture Meubles J.R. Lagacé Inc. Atholville 680277 2015 01 01
Ironstone Enterprises Bradley Gillcash Dundas 680283 2015 01 02
The Royal Gazette — January 21, 2015 81 Gazette royale — 21 janvier 2015
NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUM
Partnerships and Business Names Registration Act / Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales
In relation to the certificate of business name registered on December 14, 2014 under the Act, under the name of “The Urban Nest Gifts & Decor”,
being file #679948, notice is given that pursuant to s.17 of the Act, the Registrar has ordered that the address at section 6 be corrected to read as
follows: “Douglastown Plaza, 3 Renaud Street, Miramichi, NB”.
Sachez que, relativement à un certificat d’appellation commerciale enregistré le 14 décembre 2014 en vertu de la Loi sous le nom de «The Urban
Nest Gifts & Decor », dont le numéro d’appellation commerciale est 679948, le registraire a ordonné, conformément à l’article 17 de la Loi, que
l’adresse à la section 6 soit corrigée pour qu’elle se lise comme suit : « Douglastown Plaza, 3 Renaud Street, Miramichi, NB ».
_____________________________________________________
MOUNTAIN MAPLES Leslie C. Stiles Elgin 319142 2015 01 01
SLEEMAN BREWING & MALTING
CO. SLEEMAN BREWERIES LTD./
BRASSERIE SLEEMAN LTEE Saint John 347657 2014 12 29
STROH CANADA SLEEMAN BREWERIES LTD./
BRASSERIE SLEEMAN LTEE Saint John 347762 2014 12 29
IRVING TISSUE Irving Consumer Products
Limited Les Produits de
Consommation Irving Limitée
Dieppe 350888 2015 01 01
IRVING TISSUE COMPANY Irving Consumer Products
Limited Les Produits de
Consommation Irving Limitée
Saint John 350889 2015 01 01
Sussex Towing 504741 N.B. LTD. Passekeag 609318 2014 12 19
Les Papiers Irving Irving Consumer Products
Limited Les Produits de
Consommation Irving Limitée
Dieppe 609364 2015 01 01
GNR Sales & Service Gabriel Cormier Irishtown 610248 2014 12 17
VALLEY CLEANERS Mark Wayne Hovey Valley Road 610511 2014 12 18
Jessica Rhaye Music Jessica Grimmer Hampton 610521 2014 12 18
DEWITT LINGUISTIC SERVICES Steven Dewitt Fredericton 610552 2014 12 22
SLEEMAN MARITIMES SLEEMAN BREWERIES LTD./
BRASSERIE SLEEMAN LTEE Saint John 611699 2014 12 29
Fireball Gallery & Studio D. Lynne Bowland Lord’s Cove 615858 2014 12 27
BEAULIEU ALUMINIUM GROUPE DEAN DAIGLE
GROUP INC. Edmundston 616026 2014 12 23
RED BULL BEER COMPANY SLEEMAN BREWERIES LTD./
BRASSERIE SLEEMAN LTEE Saint John 622350 2014 12 29
Roy Auto St-Quentin Joël Roy Saint-Quentin 629980 2014 12 30
Ecole DansEncorps School Chantal Cadieux Moncton 645712 2014 12 22
Around the Block Contracting Michael Parker Weldon 646445 2014 12 19
JONES GALLERY Sarah Jones Saint John 647031 2014 12 30
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and
Business Names Registration Act, a certificate of renewal of business
name has been registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en
nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-
nouvellement d’appellation commerciale a été enregistré :
Registrant of Address of Business Reference
Certificate or Agent Number Date
Enregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale du certificat du représentant férence année mois jour
The Royal Gazette — January 21, 2015 82 Gazette royale — 21 janvier 2015
Le Festival de Canneberge du
Canada Atlantique Village de Rogersville Rogersville 647032 2014 12 23
Festival de la Récolte Canneberge
à Rogersville Village de Rogersville Rogersville 647033 2014 12 23
Célébration de la Récolte des
canneberges Village de Rogersville Rogersville 647034 2014 12 23
Capital City Toy Store 645062 NB Inc. Hanwell 647121 2014 12 19
The Raven’s Tree Natural Body
Soaps & Creams Ramona Leduc Rusagonis 647756 2014 12 24
DON’S AUTO REPAIR AND
SERVICE Donald LeBlanc Memramcook 648044 2014 12 29
COLES INDIGO BOOKS & MUSIC INC. Fredericton 648050 2014 12 16
Sodexo Services Canada Sodexo Canada Ltd. Saint John 648998 2014 12 22
STEP UP FOR LIFE MONCTON CRISIS
PREGNANCY
CENTRE, INC.
Moncton 649373 2014 12 18
_____________________________________________________
STEEVES PORTER HE’TU Rothesay 348564 2014 12 23
Fredericton Hyundai Fredericton 609638 2014 12 22
TRI STAR FINE CARS Saint John 614095 2015 01 01
B&J AUTO SERVICES Dalhousie 621293 2014 12 23
Fancy Coffee Services Riverbank 622072 2014 12 23
THERRIEN FABRICATION Edmundston 625768 2014 12 23
HOLIDAY RESTAURANT Cambridge-Narrows 627900 2014 12 18
Down East Window & Door Sussex 643902 2014 12 23
Candle in the window primitives Boiestown 655654 2014 12 31
O’LEARY AUTO GROUP Fredericton 664093 2014 12 22
Boutique Bébé tout neuf Tracadie-Sheila 664577 2014 12 31
Your Ideal Weigh Fredericton 667771 2014 12 29
Design Right Canada Saint John 674790 2015 01 01
A.W.O.L. Brewery Riverview 675208 2014 12 22
Newmarket Forest Ventures Newmarket 675713 2014 12 31
Bronsage ZANA Kedgwick 679406 2014 12 23
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and
Business Names Registration Act, a certificate of cessation of busi-
ness or use of business name has been registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en
nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessa-
tion de l’activité ou de cessation d’emploi de l’appellation com-
merciale a été enregistré :
Reference
Number Date
Address / Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Adresse férence année mois jour
The Royal Gazette — January 21, 2015 83 Gazette royale — 21 janvier 2015
D.S. Forma-Soins Edmundston 679734 2014 12 18
The Urban Nest Gifts & Decor Miramichi 679948 2014 12 29
_____________________________________________________
Indigo Michael Connors
Fredericton 638727 2014 12 16
_____________________________________________________
East Coast Beef Jerky Tracey Johnston
Randy Johnston Sackville 679870 2014 12 19
D.S. Forma-Soins Sylvie Gaumont
Denis Chouinard Edmundston 680060 2014 12 18
The Urban Nest Gifts & Decor Laura St. Coeur
Wade St. Coeur Miramichi 680191 2014 12 29
_____________________________________________________
CROSSFIT SAINT JOHN Michael Jackson
Amy Wilkins Saint John 646912 2014 12 18
_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and
Business Names Registration Act, a certificate of change of agent for
service has been registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en
nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de chan-
gement d’un représentant pour fin de signification a été déposé :
Reference
Number Date
Agent and Address / Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Représentant et adresse férence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and
Business Names Registration Act, a certificate of partnership has
been registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur lenregistrement des sociétés en
nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de so-
ciété en nom collectif a été enregistré :
Address of Business Reference
or Agent Number Date
Adresse du commerce Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Partners / Membres ou du représentant référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and
Business Names Registration Act, a certificate of renewal of part-
nership has been registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur lenregistrement des sociétés en
nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-
nouvellement de société en nom collectif a été enregistré :
Address of
Business or Agent Reference
Adresse du Number Date
commerce ou Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Partners / Membres du représentant référence année mois jour
The Royal Gazette — January 21, 2015 84 Gazette royale — 21 janvier 2015
Lemieux Ménard & Co. Saint-Antoine 666665 2014 12 31
J and R Cleaning Service Fredericton 676965 2014 12 31
ENBRIDGE GAS NEW BRUNSWICK
LIMITED PARTNERSHIP Enbridge Gas New
Brunswick Inc./
Enbridge Gaz Nouveau-
Brunswick
Fredericton 400538 2014 12 22
Agartis LP Tortora, Julien F.R. Saint John 680173 2014 12 23
_____________________________________________________
Trimac Transportation Services
Limited Partnership Saint John Alberta Stewart McKelvey
Corporate Services
(NB) Inc.
Saint John
616032 2014 12 22
DOLLARAMA L.P. -DOLLARAMA
S.E.C. Saint John Québec / Quebec Stewart McKelvey
Corporate Services
(NB) Inc.
Saint John
616403 2014 12 17
Marketwired Holding L.P. Saint John Manitoba Stewart McKelvey
Corporate Services
(NB) Inc.
Saint John
675396 2014 12 23
Marketwired L.P. Saint John Ontario Stewart McKelvey
Corporate Services
(NB) Inc.
Saint John
680155 2014 12 23
_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and
Business Names Registration Act, a certificate of dissolution of part-
nership has been registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur lenregistrement des sociétés en
nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de disso-
lution de société en nom collectif a été enregistré :
Reference
Number Date
Address / Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Adresse férence année mois jour
Loi sur les sociétés en commanditeLimited Partnership Act
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-
ship Act, a declaration of limited partnership has been filed by: SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une
déclaration de société en commandite a été déposée par :
Principal place in Reference
New Brunswick Number Date
General Partners Principal établissement au Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Commandités Nouveau-Brunswick référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-
ship Act, a declaration of extra-provincial limited partnership has
been filed:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une
déclaration de société en commandite extraprovinciale a été dépo-
sée par :
Principal place in Reference
New Brunswick Agent and Address Number Date
Principal établissement au Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Nouveau-Brunswick Compétence et adresse férence année mois jour
The Royal Gazette — January 21, 2015 85 Gazette royale — 21 janvier 2015
Marketwired Holding L.P. Marketwire L.P. Manitoba Stewart McKelvey
Corporate Services
(NB) Inc.
Saint John
675396 2014 12 23
_____________________________________________________
MARRET HIGH GRADE HEDGE LIMITED
PARTNERSHIP Ontario Stewart McKelvey Corporate
Services (NB) Inc.
Saint John
648101 2014 12 24
_____________________________________________________
Marketwired Holding L.P. Ontario Marketwired Canada
Limited Saint John 675396 2014 12 23
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-
ship Act, a declaration of extra-provincial limited partnership,
which includes a name change, has been filed:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une
déclaration de société en commandite extraprovinciale, contenant
une nouvelle raison sociale, a été déposée par :
Reference
Agent and Address Number Date
Previous Name Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Ancienne raison sociale Compétence et adresse référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-
ship Act, a declaration of withdrawal of extra-provincial limited
partnership has been filed:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une
déclaration de retrait de société en commandite extraprovinciale a
été déposée par :
Reference
Agent and Address Number Date
Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Compétence et adresse référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-
ship Act, a declaration of change of limited partnership or extra-
provincial limited partnership has been filed:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une
déclaration de changement de socié en commandite ou de société
en commandite extraprovinciale a été déposée :
Principal place in Reference
New Brunswick Number Date
Jurisdiction General Partners Principal établissement au Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Compétence Commandités Nouveau-Brunswick référence année mois jour
NOTICE OF SALE FOR REMOVAL
Camp
Lot 1
Black Top Mountain Group
Off Charlo Road, Black Top Mountain
Restigouche County, N.B.
One storey camp on Lot 1, Black Top Mountain Group, off
Charlo Road, Black Top Mountain, Restigouche County, N.B.
For inspection, contact Natural Resources’ Campbellton Office,
at 506-789-2336. Refer to Tender No. 15-L0045 on all commu-
nications. A property value of $500 has been placed on this
asset.
Department of Transportation
and Infrastructure
AVIS DE VENTE ET D’ENLÈVEMENT
Camp
Lot 1
Groupe du Mont Black Top
En retrait du chemin Charlo, Black Top Mountain
Comté de Restigouche (N.-B.)
Camp d’un étage situé sur lot 1, groupe du Mont Black Top, en
retrait du chemin Charlo, Black Top Mountain, comté de
Restigouche (N.-B.). Pour l’inspection, communiquer avec le
bureau du ministère des Ressources naturelles de Campbellton,
au 506-789-2336. Mentionner l’appel d’offres no 15-L0045
dans toutes les communications. La valeur du bien est de 500 $.
Ministère des Transports
et de l’Infrastructure
The Royal Gazette — January 21, 2015 86 Gazette royale — 21 janvier 2015
Dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception de
l’acte de vente, l’acheteur peut faire une demande au ministère
des Ressources naturelles pour un bail de lieu de camp.
Valeur du bien : 500 $
Date de fermeture : le 26 janvier 2015
Pour les conditions de soumission :
http://www.gnb.ca/2221/index-f.asp
Appeler : 506-453-2221
Par courriel : pearl.black@gnb.ca
Mentionner : l’appel d’offres no 15-L0045
Le ministre des Transports et de l’Infrastructure
L’Hon. Roger Melanson
Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces
L.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2)
Destinataire : Wendell Philip Morris, débiteur hypothécaire ori-
ginaire et propriétaire du droit de rachat; et tout autre intéressé
éventuel. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte
d’hypothèque et de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19.
Biens en tenure libre situés au 104, promenade Islandview, à
Miramichi, comté de Northumberland, province du Nouveau-
Brunswick, et ayant le NID 40220915.
Avis de vente donné par la Banque Toronto-Dominion, créan-
cière hypothécaire et titulaire de l’hypothèque. La vente aura
lieu le jeudi 29 janvier 2015, à 11 h, heure locale, au palais de
justice de Miramichi, 673, route King George, Miramichi
(Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions
du 31 décembre 2014 et des 7, 14 et 21 janvier 2015 du
Miramichi Leader.
Natalie M. Stewart, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la
Banque Toronto-Dominion, Brunswick Square, bureau 1700,
1, rue Germain, C.P. 6370, Saint John (Nouveau-Brunswick)
E2L 4R8; téléphone : 506-643-6500; télécopieur : 506-643-6505
________________
DESTINATAIRES : NANCY DOREEN McKAY, du
128, cour Demille, à Hampton (Nouveau-Brunswick),
E5N 2E4, débitrice hypothécaire;
BANQUE ROYALE DU CANADA, 100, rue King, Saint
John (Nouveau-Brunswick) E2L 1G4, créancière hypothécaire;
ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.
Lieux en tenure libre situés au 50-54, rue Waterloo, à Saint
John (Nouveau-Brunswick), paroisse de Saint John, comté de
Saint John, province du Nouveau-Brunswick, dont le NID est
13847.
Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulaire
de la première hypothèque.
Avis de vente
The purchaser may within 14 days from the date of receiving a
bill of sale, make application to the Department of Natural Re-
sources for a recreational camp lot lease.
Property Value: $500
Closing Date: January 26, 2015
For tender submission criteria,
Visit: www.GNB.ca/2221
Call: 506-453-2221
E-mail: pearl.black@gnb.ca
Reference: Tender No.: 15-L0045
Hon. Roger Melanson
Minister of Transportation and Infrastructure
Sale of Lands Publication Act
R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)
To: Wendell Philip Morris, original Mortgagor and owner of the
equity of redemption; and to all others whom it may concern.
Sale pursuant to terms of the mortgage and the Property Act,
R.S.N.B. 1973, c.P-19, as amended. Freehold property situate at
104 Islandview Drive, Miramichi, in the County of Northum-
berland and Province of New Brunswick, and being identified
as PID 40220915.
Notice of Sale given by The Toronto-Dominion Bank, Mort-
gagee and holder of the mortgage. Sale to be held at the
Miramichi Law Courts, 673 King George Highway, Miramichi,
New Brunswick on Thursday, January 29, 2015, at the hour of
11:00 a.m., local time. See advertisement of Notice of Mortgage
Sale in the Miramichi Leader dated December 31, 2014, Janu-
ary 7, January 14, and January 21, 2015.
McInnes Cooper, Solicitors for The Toronto-Dominion Bank,
Per: Natalie M. Stewart, Suite 1700, Brunswick Square,
1 Germain Street, P.O. Box 6370, Saint John, New Brunswick,
E2L 4R8, Telephone: 506-643-6500, Facsimile: 506-643-6505
________________
TO: NANCY DOREEN McKAY, of 128 Demille Court,
Hampton, New Brunswick, E5N 2E4, Mortgagor;
AND TO: ROYAL BANK OF CANADA, 100 King Street,
Saint John, New Brunswick, E2L 1G4, Mortgagee;
AND TO: ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN.
Freehold premises situate, lying and being at 50-54 Waterloo
Street, Saint John, New Brunswick, in the Parish of Saint John,
County of Saint John, and Province of New Brunswick, also
known as PID 13847.
Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of the
first mortgage.
Notices of Sale
The Royal Gazette — January 21, 2015 87 Gazette royale — 21 janvier 2015
Sale on the 19th day of February, 2015, at 11:00 a.m., at the
Saint John County Registry Office at 2nd Floor, 15 King Square
North, Saint John, New Brunswick. The Mortgagee reserves the
right to postpone or reschedule the time and date of sale. See ad-
vertisement in the Telegraph-Journal.
Cox & Palmer, Solicitors for the Mortgagee, the Royal Bank of
Canada
________________
TO: NANCY DOREEN McKAY, of 128 Demille Court,
Hampton, New Brunswick, E5N 2E4, Mortgagor;
AND TO: ROYAL BANK OF CANADA, 100 King Street,
Saint John, New Brunswick, E2L 1G4, Mortgagee;
AND TO: ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN.
Freehold premises situate, lying and being at 50-54 Wright
Street, Saint John, New Brunswick, in the Parish of Saint John,
County of Saint John, and Province of New Brunswick, also
known as PID 55197511.
Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of the
first mortgage.
Sale on the 19th day of February, 2015, at 11:15 a.m., at the
Saint John County Registry Office at 2nd Floor, 15 King Square
North, Saint John, New Brunswick. The Mortgagee reserves the
right to postpone or reschedule the time and date of sale. See ad-
vertisement in the Telegraph-Journal.
Cox & Palmer, Solicitors for the Mortgagee, the Royal Bank of
Canada
________________
TO: NANCY DOREEN McKAY, of 128 Demille Court,
Hampton, New Brunswick, E5N 2E4, Mortgagor;
AND TO: ROYAL BANK OF CANADA, 100 King Street,
Saint John, New Brunswick, E2L 1G4, Mortgagee;
AND TO: ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN.
Freehold premises situate, lying and being at 102 Carleton
Street, Saint John, New Brunswick, in the Parish of Saint John,
County of Saint John, and Province of New Brunswick, also
known as PID 38133.
Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of the
first mortgage.
Sale on the 19th day of February, 2015, at 11:30 a.m., at the
Saint John County Registry Office at 2nd Floor, 15 King Square
North, Saint John, New Brunswick. The Mortgagee reserves the
right to postpone or reschedule the time and date of sale. See ad-
vertisement in the Telegraph-Journal.
Cox & Palmer, Solicitors for the Mortgagee, the Royal Bank of
Canada
________________
La vente aura lieu le 19 février 2015, à 11 h, au bureau de l’en-
registrement du comté de Saint John situé au 15, King Square
Nord, 2e étage, Saint John (Nouveau-Brunswick). La créancière
hypothécaire se réserve le droit de reporter la date et l’heure de
la vente. Voir l’annonce publiée dans le Telegraph-Journal.
Cox & Palmer, avocats de la créancière hypothécaire, la Banque
Royale du Canada
________________
DESTINATAIRES : NANCY DOREEN McKAY, du
128, cour Demille, à Hampton (Nouveau-Brunswick),
E5N 2E4, débitrice hypothécaire;
BANQUE ROYALE DU CANADA, 100, rue King, Saint
John (Nouveau-Brunswick) E2L 1G4, créancière hypothécaire;
ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.
Lieux en tenure libre situés au 50-54, rue Wright, à Saint John
(Nouveau-Brunswick), paroisse de Saint John, comté de Saint
John, province du Nouveau-Brunswick, dont le NID est
55197511.
Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulaire
de la première hypothèque.
La vente aura lieu le 19 février 2015, à 11 h 15, au bureau de
l’enregistrement du comté de Saint John situé au 15, King
Square Nord, 2e étage, Saint John (Nouveau-Brunswick). La
créancière hypothécaire se réserve le droit de reporter la date et
l’heure de la vente. Voir l’annonce publiée dans le Telegraph-
Journal.
Cox & Palmer, avocats de la créancière hypothécaire, la Banque
Royale du Canada
________________
DESTINATAIRES : NANCY DOREEN McKAY, du
128, cour Demille, à Hampton (Nouveau-Brunswick),
E5N 2E4, débitrice hypothécaire;
BANQUE ROYALE DU CANADA, 100, rue King, Saint
John (Nouveau-Brunswick) E2L 1G4, créancière hypothécaire;
ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.
Lieux en tenure libre situés au 102, rue Carleton, à Saint John
(Nouveau-Brunswick), paroisse de Saint John, comté de Saint
John, province du Nouveau-Brunswick, dont le NID est 38133.
Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulaire
de la première hypothèque.
La vente aura lieu le 19 février 2015, à 11 h 30, au bureau de
l’enregistrement du comté de Saint John situé au 15, King
Square Nord, 2e étage, Saint John (Nouveau-Brunswick). La
créancière hypothécaire se réserve le droit de reporter la date et
l’heure de la vente. Voir l’annonce publiée dans le Telegraph-
Journal.
Cox & Palmer, avocats de la créancière hypothécaire, la Banque
Royale du Canada
________________
The Royal Gazette — January 21, 2015 88 Gazette royale — 21 janvier 2015
609508 NB INC., of 270 Orleans Street, Dieppe, New
Brunswick, E1A 5E2, Mortgagor; JOSEPH MICHEL
WILLIAM COMEAU, of 270 Orleans Street, Dieppe, New
Brunswick, E1A 5E2, Guarantor; TRESCO HOLDINGS
INC., Mortgagee and present holder of the First Mortgage; and
to all others to whom it in any way may concern. Notice of Sale
given by TRESCO HOLDINGS INC., the Mortgagee and
present holder of the First Mortgage. Freehold lands situate at
53 Water Street, Campbellton, Parish of Addington, County of
Restigouche and Province of New Brunswick. Sale on Monday,
the 16th day of February, A.D., 2015, at the hour of 11:00
o’clock in the forenoon, at or near the main entrance to the
County Court House, located at the City Centre Mall, Suite 202,
157 Water Street, P.O. Box 5001, Campbellton, in the County of
Restigouche, and Province of New Brunswick.
SEE ADVERTISEMENT IN THE TRIBUNE.
CYRIL C. SUTHERLAND, SOLICITOR FOR THE
FIRST MORTGAGEE: TRESCO HOLDINGS INC.
________________
PROVINCE OF NEW BRUNSWICK
COUNTY OF CHARLOTTE
NOTICE OF SALE
TO: CLARENCE EDWARD GIBSON & DEBORAH ANN
GIBSON, Owners of the Equity of Redemption and Original
Mortgagors; GARY GIBSON, Guarantor; BHM FINANCIAL
GROUP, Judgment Creditor; and to all others whom it may
concern.
NOTICE IS HEREBY GIVEN under and by virtue of the pro-
visions of the Property Act, being Chapter P-19, R.S.N.B., 1973
and amendments thereto and by virtue of the provisions con-
tained in a certain Indenture of Mortgage bearing date the 17th
day of January, 2012 and registered in the Charlotte County
Land Titles Office on the 18th day of January, 2012 as Number
31071567 and made between CLARENCE EDWARD
GIBSON & DEBORAH ANN GIBSON, as Mortgagor and
GARY GIBSON, as Guarantor and WILLOWRICH INVEST-
MENT FUND, as Mortgagee, there will, for the purpose of ob-
taining payment of monies secured by the said Indenture of
Mortgage, default having been made in the payment thereof, be
sold at public auction at Service New Brunswick, 93 Milltown
Boulevard, St. Stephen, New Brunswick, on 10th day of Febru-
ary, 2015, at the hour of eleven o’clock (11:00 a.m.) in the fore-
noon, local time:
PID #15060221 – being property located at 132 Route 725,
Little Ridge, New Brunswick and 134 Route 725, Little
Ridge, New Brunswick
TOGETHER WITH all buildings and improvements thereon
and the rights, privileges and appurtenances to the same belong-
ing.
AND FURTHER TAKE NOTICE that if a sufficient offer of
purchase is not received for the said lands and premise at such
public auction, the same may be withdrawn from such sale and
disposed of by private contract without further notice being
given.
609508 NB INC., du 270, rue Orléans, Dieppe (Nouveau-
Brunswick), E1A 5E2, débitrice hypothécaire; JOSEPH
MICHEL WILLIAM COMEAU, du 270, rue Orléans,
Dieppe (Nouveau-Brunswick), E1A 5E2, garant; TRESCO
HOLDINGS INC., créancière hypothécaire et titulaire actuelle
de la première hypothèque; et tout autre intéressé éventuel. Avis
de vente donné par TRESCO HOLDINGS INC., créancière
hypothécaire et titulaire actuelle de la première hypothèque.
Terrains en tenure libre situés au 53, rue Water, à Campbellton,
paroisse d’Addington, comté de Restigouche, province du
Nouveau-Brunswick. La vente aura lieu le lundi 16 février
2015, à 11 h, dans l’entrée principale du palais de justice du
comté, ou tout près, situé au Mall Centre-Ville, 157, rue Water,
bureau 202, C.P. 5001, Campbellton, comté de Restigouche,
province du Nouveau-Brunswick.
VOIR L’ANNONCE PUBLIÉE DANS THE TRIBUNE.
CYRIL C. SUTHERLAND, AVOCAT DE LA PREMIÈRE
CRÉANCIÈRE HYPOTHÉCAIRE, TRESCO HOL-
DINGS INC.
________________
PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
COMTÉ DE CHARLOTTE
AVIS DE VENTE
DESTINATAIRES : CLARENCE EDWARD GIBSON ET
DEBORAH ANN GIBSON, propriétaires du droit de rachat et
débiteurs hypothécaires; GARY GIBSON, garant; BHM FI-
NANCIAL GROUP, créancier sur jugement; et tout autre inté-
ressé éventuel.
AVIS est par les présentes donné conformément aux disposi-
tions de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19, et en vertu
des dispositions contenues dans l’acte d’hypothèque établi le
17 janvier 2012 et enregistré au bureau de l’enregistrement fon-
cier du comté de Charlotte le 18 janvier 2012, sous le numéro
31071567, entre CLARENCE EDWARD GIBSON ET
DEBORAH ANN GIBSON, débiteurs hypothécaires, et GARY
GIBSON, garant, et WILLOWRICH INVESTMENT FUND,
créancière hypothécaire, que seront vendus aux enchères pu-
bliques en vue d’acquitter les sommes garanties par ledit acte
d’hypothèque, étant donné le défaut d’en effectuer le paiement,
à Services Nouveau-Brunswick, 93, boulevard Milltown,
St. Stephen (Nouveau-Brunswick), le 10 février 2015, à 11 h,
heure locale :
le NID 15060221, correspondant aux biens situés au
132, route 725, Little Ridge (Nouveau-Brunswick) et au
134, route 725, Little Ridge (Nouveau-Brunswick)
AINSI QUE tous les bâtiments qui s’y trouvent et les améliora-
tions qui y ont été apportées, ainsi que les droits, les privilèges
et les dépendances qui s’y rattachent.
SACHEZ AUSSI qu’à défaut de recevoir une offre d’achat suf-
fisante pour lesdits terrains et bâtiments dans le cadre de la
vente aux enchères publique, ceux-ci pourraient être retirés de
la vente et vendus par contrat privé sans autre avis.
The Royal Gazette — January 21, 2015 89 Gazette royale — 21 janvier 2015
DATED at Woodstock, New Brunswick, this 7th day of January,
2015.
WILLOWRICH INVESTMENT FUND
PETER A. BREWER, Solicitor for Willowrich Investment
Fund, Brewer Law Offices, 4-113 Broadway, Woodstock, NB
E7M 6B4, 506-325-2220
________________
Sale of Lands Publication Act
R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)
To: Line Anne Gallant Hebert and Claude Hebert, original
Mortgagors; and to all others whom it may concern. Sale pursu-
ant to terms of the Mortgage and the Property Act R.S.N.B.,
1973, c.P-19 and Acts in amendment thereof. Freehold property
being situated at 896 Walden Street, Miramichi, New
Brunswick, the same lot conveyed to Line Anne Gallant Hebert
and Claude Hebert by Transfer registered in the Land Titles
System on May 4, 2012, as document number 31427835.
Notice of Sale given by Bank of Nova Scotia as Mortgagee.
Sale to be held at or near the front of the Court House for the
Judicial District of Miramichi, 673 King George Highway,
Miramichi, New Brunswick on the 13th day of February, 2015,
at the hour of 11:00 a.m., local time. See advertisement of No-
tice of Sale in the Miramichi Leader dated January 14, January
21, January 28 and February 4, 2015.
McInnes Cooper, Solicitors for Bank of Nova Scotia, Per: Adel
Gönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400, P.O.
Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6, Telephone:
506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095
________________
TO: SHERRY DAWN SPENCER and THE ESTATE OF
VINCENT RUSSELL SPENCER, Mortgagors;
AND TO: ALL OTHERS TO WHOM IT MAY CONCERN.
Sale conducted under the terms of the first mortgage under the
Property Act, R.S.N.B., 1973, c.P-19, s.44 as amended. Free-
hold property situate at 42 Labelle Street, Moncton, Westmor-
land County, Province of New Brunswick and known as Parcel
Identifier Number 70387360.
Notice of Sale is given by TD FINANCING SERVICES
HOME INC.
The sale is scheduled for Thursday, February 12, 2015, at 11:15
a.m., at the Moncton City Hall, 655 Main Street, Moncton, New
Brunswick.
See advertisements in the Times & Transcript in the issues of
January 14, January 21, January 28, and February 4, 2015.
TD FINANCING SERVICES HOME INC., By: LAWSON
CREAMER, Per: Veronica L. Ford, Solicitors for the TD Fi-
nancing Services Home Inc.
________________
FAIT à Woodstock, au Nouveau-Brunswick, le 7 janvier 2015.
WILLOWRICH INVESTMENT FUND
PETER A. BREWER, avocat de Willowrich Investment Fund,
Brewer Law Offices, 4-113, rue Broadway, Woodstock
(Nouveau-Brunswick) E7M 6B4, 506-325-2220
________________
Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces
L.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2)
Destinataires : Line Anne Gallant Hebert et Claude Hebert, dé-
biteurs hypothécaires originaires; et tout autre intéressé éven-
tuel. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypo-
thèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973,
c.P-19. Biens en tenure libre situés au 896, rue Walden, à
Miramichi (Nouveau-Brunswick), correspondant au même lot
ayant été transféré à Line Anne Gallant Hebert et Claude Hebert
par l’acte de transfert enregistré dans le système d’enregistre-
ment foncier le 4 mai 2012, sous le numéro 31427835.
Avis de vente donné par la Banque de Nouvelle-Écosse, créan-
cière hypothécaire. La vente aura lieu le 13 février 2015, à 11 h,
heure locale, devant le palais de justice de la circonscription ju-
diciaire de Miramichi, ou tout près, 673, route King George,
Miramichi (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans
les éditions des 14, 21 et 28 janvier et du 4 février 2015 du
Miramichi Leader.
Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Banque
de Nouvelle-Écosse, Centre de la Croix Bleue, bureau S400,
644, rue Main, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick)
E1C 8T6; téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095
________________
DESTINATAIRES : SHERRY DAWN SPENCER et LA
SUCCESSION DE VINCENT RUSSELL SPENCER, débi-
teurs hypothécaires;
ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.
Vente effectuée en vertu des dispositions du premier acte d’hy-
pothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973,
c.P-19, art.44. Biens en tenure libre situés au 42, rue Labelle, à
Moncton, comté de Westmorland, province du Nouveau-
Brunswick, et dont le numéro d’identification parcellaire est
70387360.
Avis de vente donné par SERVICES DE FINANCEMENT TD
RÉSIDENTIEL INC.
La vente aura lieu le jeudi 12 février 2015, à 11 h 15, à l’hôtel
de ville de Moncton, 655, rue Main, Moncton (Nouveau-
Brunswick).
Voir l’annonce publiée dans les éditions des 14, 21 et 28 janvier
et du 4 février 2015 du Times & Transcript.
Veronica L. Ford, du cabinet LAWSON CREAMER, avo-
cats de Services de financement TD résidentiel Inc.
________________
The Royal Gazette — January 21, 2015 90 Gazette royale — 21 janvier 2015
TO: MARIE JEANNE DUPLESSIS, also known as
JEANNE M. DUPLESSIS, and MOISE DUPLESSIS, Mort-
gagors;
AND TO: ALL OTHERS TO WHOM IT MAY CONCERN.
Sale conducted under the terms of the first mortgage under the
Property Act, R.S.N.B., 1973, c.P-19, s.44 as amended. Free-
hold property situate at 234 Weisner Road, Lakeville-
Westmorland, Westmorland County, Province of New
Brunswick and known as Parcel Identifier Number 70202528.
Notice of Sale is given by TD FINANCING SERVICES
HOME INC.
The sale is scheduled for Thursday, February 12, 2015, at 11:00
a.m., at the Moncton City Hall, 655 Main Street, Moncton, New
Brunswick.
See advertisements in the Times & Transcript in the issues of
January 14, January 21, January 28, and February 4, 2015.
TD FINANCING SERVICES HOME INC., By: LAWSON
CREAMER, Per: Veronica L. Ford, Solicitors for the TD Fi-
nancing Services Home Inc.
________________
Sale of Lands Publication Act
R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)
To: Chantale Lorraine Humble and Dale Charles Humble, orig-
inal Mortgagors; and to all others whom it may concern. Sale
pursuant to terms of the Mortgage and the Property Act
R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts in amendment thereof. Free-
hold property being situated at 181 Graveyard Hill, Stanley,
New Brunswick, the same lot conveyed to Chantale Lorraine
Humble and Dale Charles Humble by Transfer registered in the
Land Titles System on March 28, 2008, as document number
25348336.
Notice of Sale given by Scotia Mortgage Corporation as Mort-
gagee. Sale to be held at the Fredericton Justice Building lo-
cated at 427 Queen Street, Fredericton, New Brunswick on the
12th day of February, 2015, at the hour of 11:00 a.m., local time.
See advertisement of Notice of Mortgage Sale in The Daily
Gleaner dated January 14, January 21, January 28 and February
4, 2015.
McInnes Cooper, Solicitors for Scotia Mortgage Corporation,
Per: Adel Gönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite
S400, P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6,
Telephone: 506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095
________________
Sale of Lands Publication Act
R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)
To: Timothy Ryan Turner, original Mortgagor; and to all others
whom it may concern. Sale pursuant to terms of the Mortgage
and the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts in amend-
ment thereof. Freehold property being situated at 2395 Route
845, Bayswater, New Brunswick, the same lot conveyed to
Timothy Ryan Turner by Transfer registered in the Land Titles
System on April 3, 2006, as document number 21908984.
DESTINATAIRES : MARIE JEANNE DUPLESSIS, égale-
ment connue sous le nom de JEANNE M. DUPLESSIS et
MOISE DUPLESSIS, débiteurs hypothécaires;
ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.
Vente effectuée en vertu des dispositions du premier acte d’hy-
pothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973,
c.P-19, art.44. Biens en tenure libre situés au 234, chemin
Weisner, à Lakeville, comté de Westmorland, province du
Nouveau-Brunswick, et dont le numéro d’identification parcel-
laire est 70202528.
Avis de vente donné par SERVICES DE FINANCEMENT TD
RÉSIDENTIEL INC.
La vente aura lieu le jeudi 12 février 2015, à 11 h, à l’hôtel de
ville de Moncton, 655, rue Main, Moncton (Nouveau-
Brunswick).
Voir l’annonce publiée dans les éditions des 14, 21 et 28 janvier
et du 4 février 2015 du Times & Transcript.
Veronica L. Ford, du cabinet LAWSON CREAMER, avo-
cats de Services de financement TD résidentiel inc.
________________
Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces
L.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2)
Destinataires : Chantale Lorraine Humble et Dale Charles
Humble, débiteurs hypothécaires; et tout autre intéressé éven-
tuel. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypo-
thèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973,
c.P-19. Biens en tenure libre situés au 181, Graveyard Hill, à
Stanley (Nouveau-Brunswick), et correspondant au même lot
ayant été transféré à Chantale Lorraine Humble et Dale Charles
Humble par l’acte de transfert enregistré dans le système d’en-
registrement foncier le 28 mars 2008, sous le numéro
25348336.
Avis de vente donné par la Société hypothécaire Scotia, créan-
cière hypothécaire. La vente aura lieu le 12 février 2015, à 11 h,
heure locale, au palais de justice de Fredericton, 427, rue
Queen, Fredericton (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce pu-
bliée dans les éditions des 14, 21 et 28 janvier et du 4 février
2015 du Daily Gleaner.
Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Société
hypothécaire Scotia, Centre de la Croix Bleue, bureau S400,
644, rue Main, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick)
E1C 8T6; téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095
________________
Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces
L.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2)
Destinataire : Timothy Ryan Turner, débiteur hypothécaire ori-
ginaire; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée en vertu
des dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur
les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenure libre situés au
2395, route 845, à Bayswater (Nouveau-Brunswick), et corres-
pondant au même lot ayant été transféré à Timothy Ryan Turner
par l’acte de transfert enregistré dans le système d’enregistre-
ment foncier le 3 avril 2006, sous le numéro 21908984.
The Royal Gazette — January 21, 2015 91 Gazette royale — 21 janvier 2015
Notice of Sale given by HSBC Bank Canada as Mortgagee. Sale
to be held at the Saint John Provincial Building located at
10 Peel Plaza, Saint John, New Brunswick on the 12th day of
February, 2015, at the hour of 11:00 a.m., local time. See adver-
tisement of Notice of Mortgage Sale in the Telegraph-Journal
dated January 14, January 21, January 28 and February 4, 2015.
McInnes Cooper, Solicitors for HSBC Bank Canada, Per: Tony
S. Richardson, Barker House, Suite 600, 570 Queen Street, P.O.
Box 610, Station A, Fredericton, New Brunswick, E3B 5A6,
Telephone: 506-458-8572, Facsimile: 506-458-9903
The Royal Gazette is published every Wednesday under the
authority of the Queen’s Printer Act. Documents must be re-
ceived by the Royal Gazette Coordinator, Legislative
Services, no later than noon, at least seven days prior to
Wednesday’s publication. Each document must be separate
from the covering letter. Signatures on documents must be im-
mediately followed by the printed name. The Royal Gazette
Coordinator may refuse to publish a document if any part of it
is illegible, and may delay publication of any document for ad-
ministrative reasons.
Prepayment is required for the publication of all documents.
Standard documents have the following set fees:
Notices Cost per
Insertion
Notice of the intention to apply for the enactment of a
private bill $20
Originating process $ 25
Order of a court $ 25
Notice under the Absconding Debtors Act $20
Notice under the General Rules under the Law Society Act,
1996, of disbarment or suspension or of application for
reinstatement or readmission
$20
Notice of examination under the Licensed Practical Nurses
Act $25
Notice under the Motor Carrier Act $30
Any document under the Political Process Financing Act $20
Notice to creditors under New Brunswick Regulation 84-9
under the Probate Court Act $20
Notice under Rule 70 of the Rules of Court
Note: Survey Maps cannot exceed 8.5 x 14
$120
Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is
1
/2 page in length or less $20
Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is
greater than
1
/2 page in length $75
Any document under the Winding-up and Restructuring Act
(Canada) $20
Notice to Advertisers
Avis de vente donné par la Banque HSBC Canada, créancière
hypothécaire. La vente aura lieu le 12 février 2015, à 11 h,
heure locale, à l’édifice provincial de Saint John, situé au
10, place Peel, Saint John (Nouveau-Brunswick). Voir l’an-
nonce publiée dans les éditions des 14, 21 et 28 janvier et du
4 février 2015 du Telegraph-Journal.
Tony S. Richardson, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la
Banque HSBC Canada, Barker House, bureau 600, 570, rue
Queen, C.P. 610, succursale A, Fredericton (Nouveau-
Brunswick) E3B 5A6; téléphone : 506-458-8572; télécopieur :
506-458-9903
La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformé-
ment à la Loi sur l’Imprimeur de la Reine. Les documents à
publier doivent parvenir à la coordonnatrice de la Gazette
royale, aux Services législatifs, à midi, au moins sept jours
avant le mercredi de publication. Chaque avis doit être séparé
de la lettre d’envoi. Les noms des signataires doivent suivre
immédiatement la signature. La coordonnatrice de la Gazette
royale peut refuser de publier un avis dont une partie est illi-
sible et retarder la publication d’un avis pour des raisons ad-
ministratives.
Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis.
Voici les tarifs pour les avis courants :
Avis Coût par
parution
Avis d’intention de demander l’adoption d’un projet de loi
d’intérêt privé 20 $
Acte introductif d’instance 25 $
Ordonnance rendue par une cour 25 $
Avis exigé par la Loi sur les débiteurs en fuite 20 $
Avis de radiation ou de suspension ou de demande de
réintégration ou de réadmission, exigé par les Règles
générales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur le
Barreau
20 $
Avis d’examen exigé par la Loi sur les infirmières et
infirmiers auxiliaires autorisés 25 $
Avis exigé par la Loi sur les transports routiers 30 $
Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur le
financement de l’activité politique 20 $
Avis aux créanciers exigé par le Règlement du Nouveau-
Brunswick 84-9 établi en vertu de la Loi sur la Cour des
successions
20 $
Avis exigé par la Règle 70 des Règles de procédure
Nota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 po
sur 14 po
120 $
Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voie
d’annonces, si l’avis est d’une demi-page ou moins en
longueur
20 $
Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voie
d’annonces, si l’avis est de plus d’une demi-page en
longueur
75 $
Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur les
liquidations et les restructurations (Canada) 20 $
Avis aux annonceurs
The Royal Gazette — January 21, 2015 92 Gazette royale — 21 janvier 2015
Payments can be made by cash, MasterCard, VISA, cheque or
money order (payable to the Minister of Finance). No refunds
will be issued for cancellations.
The official version of The Royal Gazette is available free
on-line each Wednesday. This free on-line service replaces the
printed annual subscription service. The Royal Gazette can be
accessed on-line at:
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/
attorney_general/royal_gazette.html
Print-on-demand copies of The Royal Gazette are available, at
the following address, at $4.00 per copy plus 5% tax, plus
shipping and handling where applicable.
Legislative Services
Office of the Attorney General
Chancery Place
675 King Street
P.O. Box 6000
Fredericton, NB E3B 5H1
Tel: 506-453-8372
E-mail: gazette@gnb.ca
Note: Deliveries are to be addressed to The Royal Gazette and
left with the Commissionaire.
Notice of a correction charge is
the same as
for publishing
the original
document
Any other document $3.50 for each
cm or less
Les paiements peuvent être faits en espèces, par carte de
crédit MasterCard ou VISA, ou par chèque ou mandat (à
l’ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement ne
sera effectué en cas d’annulation.
La version officielle de la Gazette royale est disponible gra-
tuitement et en ligne chaque mercredi. Ce service gratuit en
ligne remplace le service d’abonnement annuel. Vous trouve-
rez la Gazette royale à l’adresse suivante :
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/
procureur_general/gazette_royale.html
Nous offrons, sur demande, des exemplaires de la Gazette
royale, à l’adresse suivante, pour la somme de 4 $ l’exem-
plaire, plus la taxe de 5 %, ainsi que les frais applicables de
port et de manutention.
Services législatifs
Cabinet du procureur général
Place Chancery
675, rue King
C.P. 6000
Fredericton (N.-B.) E3B 5H1
Tél. : 506-453-8372
Courriel : gazette@gnb.ca
Note : Toute livraison étant adressée à la Gazette royale doit
être remise au commissionnaire.
Avis d’une correction les frais sont
les mêmes que
ceux imposés
pour la
publication du
document
original
Tout autre document 3,50 $ pour
chaque cm ou
moins
QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK
©
IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK
All rights reserved / Tous droits réservés

Navigation menu